BLSSP (PHC 3) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBLSSP (PHC 3) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04104026
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BLSSP (PHC 3) LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra BLSSP (PHC 3) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BLSSP (PHC 3) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLSSP (PHC 3) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Dividend / re strike off application 23/10/2019
    RES13

    Cese del nombramiento de James Watson como director el 23 oct 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Bruce Richardson como director el 23 oct 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Andrew Honeyman como director el 23 oct 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Hursh Shah como director el 23 oct 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Dean Clegg como director el 23 oct 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Martyn Stephen Burke como director el 23 oct 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019

    21 páginasAA

    Nombramiento de Mr Bruce Richardson como director el 14 jun 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Clifford Wheeler como director el 14 jun 2019

    1 páginasTM01

    Estado de capital el 05 jun 2019

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Sarah Nelson como director el 14 ene 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Clifford Wheeler como director el 14 ene 2019

    2 páginasAP01

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 4

    5 páginasMR05

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 2

    5 páginasMR05

    ¿Quiénes son los directivos de BLSSP (PHC 3) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro8992198
    187856670001
    COWEN, Geraint Jamie
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director141040000003
    PINKSTONE, James Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishCorporate Finance Executive241498640001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secretario
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Director
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    ATKINSON, William Stephen
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Surveyor174566650001
    BAGULEY, Peter Jeffrey
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    Director
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    United KingdomBritishChartered Surveyor175617500001
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Director
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BELL-BROWN, Philip
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director119073370001
    BIRCH, John Matthew
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director191027500001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Director
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    BURKE, Martyn Stephen
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director152531940004
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CLEGG, Dean
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director189632520001
    COHEN, Carolina Alfred
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishInvestment Executive248093020001
    FLEMING, Richard Alexander
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant125990210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Director
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    FRANCIS, Luke Thomas
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant223122340001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HONEYMAN, James Andrew
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor201179510001
    HOORN, Antony John Van Der
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director170891040001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEWIS, Bryan John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor58257940003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Director
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MOORE, Stephen Howard
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishCorporate Finance Executive185276290002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BLSSP (PHC 3) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Blssp Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene BLSSP (PHC 3) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental deed
    Creado el 05 abr 2013
    Entregado el 23 abr 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land being north worle district centre queensway weston-super-mare north somerset t/no AV195696,l/h land on the west side of queens way worle weston-super-mare t/no AV88986 and f/h land and buildings on the west side of queensway worle weston-super-mare t/no ST210616 fixed charge all rental income any guarantee of rental income,its rights under any security or deposit agreement or arrangement see image for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited ("Borrower Security Trustee")
    Transacciones
    • 23 abr 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 07 mar 2018Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 25 ene 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Borrower deed of charge
    Creado el 28 feb 2006
    Adquirido el 05 abr 2013
    Entregado el 16 abr 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights title and interest in the existing nominee property assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited ("Borrower Security Trustee")
    Transacciones
    • 16 abr 2013Registro de una adquisición (MG06)
    • 07 mar 2018Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 25 ene 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Borrower deed of charge
    Creado el 28 feb 2006
    Entregado el 09 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee) on Trust for Itself and the Otherborrower Secured Parties
    Transacciones
    • 09 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2018Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 25 ene 2019Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar")
    Creado el 20 jun 2001
    Entregado el 06 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as the Trustee Pursuant to Thesecured Note Trust Deed (The "Secured Note Trustee") on Trust for Itself and the Other Borrowersecured Parties
    Transacciones
    • 06 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 04 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0