BLSSP (PHC 3) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BLSSP (PHC 3) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04104026 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BLSSP (PHC 3) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra BLSSP (PHC 3) LIMITED?
Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BLSSP (PHC 3) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLSSP (PHC 3) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de James Watson como director el 23 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bruce Richardson como director el 23 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Andrew Honeyman como director el 23 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hursh Shah como director el 23 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dean Clegg como director el 23 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martyn Stephen Burke como director el 23 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Bruce Richardson como director el 14 jun 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Clifford Wheeler como director el 14 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital el 05 jun 2019
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Nelson como director el 14 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Clifford Wheeler como director el 14 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 4 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 2 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BLSSP (PHC 3) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
COWEN, Geraint Jamie | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 141040000003 | ||||||||
PINKSTONE, James Michael | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Corporate Finance Executive | 241498640001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Secretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
EKPO, Ndiana | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
ADAM, Shenol | Director | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | Company Director | 2068480001 | |||||||||
ATKINSON, William Stephen | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Surveyor | 174566650001 | ||||||||
BAGULEY, Peter Jeffrey | Director | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 175617500001 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Director | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | Chartered Accountant | 32809050004 | ||||||||
BELL-BROWN, Philip | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 119073370001 | ||||||||
BIRCH, John Matthew | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 191027500001 | ||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Director | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32809000002 | ||||||||
BURKE, Martyn Stephen | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 152531940004 | ||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
CLEGG, Dean | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 189632520001 | ||||||||
COHEN, Carolina Alfred | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Investment Executive | 248093020001 | ||||||||
FLEMING, Richard Alexander | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 125990210002 | ||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||||||
FRANCIS, Luke Thomas | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Accountant | 223122340001 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
HONEYMAN, James Andrew | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 201179510001 | ||||||||
HOORN, Antony John Van Der | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 170891040001 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
LEARMONT, Richard John | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 116126860008 | ||||||||
LEARMONT, Richard John | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 116126860008 | ||||||||
LEWIS, Bryan John | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 58257940003 | ||||||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58478890003 | ||||||||
MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 58478890003 | ||||||||
METLISS, Cyril | Director | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||||||
MOORE, Stephen Howard | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | Corporate Finance Executive | 185276290002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BLSSP (PHC 3) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blssp Property Holdings Limited | 06 abr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene BLSSP (PHC 3) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental deed | Creado el 05 abr 2013 Entregado el 23 abr 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H land being north worle district centre queensway weston-super-mare north somerset t/no AV195696,l/h land on the west side of queens way worle weston-super-mare t/no AV88986 and f/h land and buildings on the west side of queensway worle weston-super-mare t/no ST210616 fixed charge all rental income any guarantee of rental income,its rights under any security or deposit agreement or arrangement see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Borrower deed of charge | Creado el 28 feb 2006 Adquirido el 05 abr 2013 Entregado el 16 abr 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All rights title and interest in the existing nominee property assets see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Borrower deed of charge | Creado el 28 feb 2006 Entregado el 09 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar") | Creado el 20 jun 2001 Entregado el 06 jul 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0