BLSSP (PHC 4) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BLSSP (PHC 4) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04104052 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BLSSP (PHC 4) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra BLSSP (PHC 4) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BLSSP (PHC 4) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLSSP (PHC 4) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 14 páginas | LIQ13 | ||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 dic 2019 | 14 páginas | LIQ03 | ||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 12 abr 2019 | 14 páginas | LIQ03 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 8-12 York Gate London NW1 4QG England a 55 Baker Street London W1U 7EU el 11 may 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2017 au 24 may 2017 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 041040520003 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cessation de Blssp Property Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 may 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 14 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Crispin James De Grave Gandy como director el 18 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Saul Jonathan Forman como director el 18 may 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de York House 45 Seymour Street London W1H 7LX a 8-12 York Gate London NW1 4QG el 26 may 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Nelson como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Bryan Lewis como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Hursh Shah como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Luke Thomas Francis como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Dean Clegg como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Martyn Stephen Burke como director el 18 may 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BLSSP (PHC 4) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAN, Saul Jonathan | Director | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 165272690001 | |||||||||
| GANDY, Crispin James De Grave | Director | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 195535830001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Secretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ADAM, Shenol | Director | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | 2068480001 | ||||||||||
| BAGULEY, Peter Jeffrey | Director | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | 175617500001 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Director | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||||||
| BELL-BROWN, Philip | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 119073370001 | |||||||||
| BIRCH, John Matthew | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 191027500001 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BRAINE, Anthony | Director | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||||||
| BURKE, Martyn Stephen | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 152531940004 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| CLEGG, Dean | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 189632520001 | |||||||||
| COWEN, Geraint Jamie | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | 141040000002 | |||||||||
| FLEMING, Richard Alexander | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 125990210002 | |||||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||||||
| FRANCIS, Luke Thomas | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 223122340001 | |||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| HOORN, Antony John Van Der | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 170891040001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEARMONT, Richard John | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 116126860008 | |||||||||
| LEWIS, Bryan John | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 58257940003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 58478890003 | |||||||||
| METLISS, Cyril | Director | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||||||
| MOORE, Stephen Howard | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 185276290002 | |||||||||
| NELSON, Sarah | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | 220620220001 | |||||||||
| O'LOAN, David Arthur | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 137230800001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BLSSP (PHC 4) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blssp Property Holdings Limited | 06 abr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Sí | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para BLSSP (PHC 4) LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 18 ene 2018 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene BLSSP (PHC 4) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 24 may 2017 Entregado el 26 may 2017 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 24 may 2017 Entregado el 25 may 2017 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Borrower deed of charge | Creado el 28 feb 2006 Entregado el 09 mar 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar") | Creado el 20 jun 2001 Entregado el 06 jul 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene BLSSP (PHC 4) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0