BLSSP (PHC 31) LIMITED

BLSSP (PHC 31) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBLSSP (PHC 31) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04104075
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BLSSP (PHC 31) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BLSSP (PHC 31) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BLSSP (PHC 31) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta19 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLSSP (PHC 31) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 06 dic 2012

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cese del nombramiento de Philip William Davies como secretario el 19 nov 2012

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Nilesh Sachdev como director el 19 nov 2012

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard John Learmont como director el 19 nov 2012

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 nov 2012

    Estado de capital el 08 nov 2012

    • Capital: GBP 438,682
    SH01

    Cese del nombramiento de John Matthew Birch como director el 22 oct 2012

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Antony John Van Der Hoorn como director el 18 abr 2012

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Alexander Fleming como director el 18 abr 2012

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 19 mar 2011

    14 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 21 jun 2011 au 20 mar 2011

    3 páginasAA01

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Cuentas completas preparadas hasta el 21 jun 2010

    17 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2011 au 21 jun 2010

    3 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 03 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    17 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 21 jun 2010 au 31 mar 2010

    3 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Charles Maudsley como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Nilesh Sachdev como director

    3 páginasAP01

    legacy

    3 páginasMG04

    Cese del nombramiento de John Rogers como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de BLSSP (PHC 31) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VAN DER HOORN, Antony John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    EnglandBritishFinance Director168662930001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secretario
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    DAVIES, Philip William
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    Secretario
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    British151995890002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Director
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    BAGULEY, Peter Jeffrey
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    Director
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    United KingdomBritishChartered Surveyor175617500001
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Director
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BIRCH, John Matthew
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director191027500001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Director
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive104301920001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    FLEMING, Richard Alexander
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant125990210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Director
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEWIS, Bryan
    26 Floyer Close
    TW10 6HS Richmond
    Surrey
    Director
    26 Floyer Close
    TW10 6HS Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor58257940002
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Director
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Director
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Director
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Director
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROGERS, John Terence
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    EnglandBritishCompany Director111235190002
    SACHDEV, Nilesh
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector116790790003
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Director
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Director designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    ¿Tiene BLSSP (PHC 31) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Borrower deed of charge
    Creado el 28 feb 2006
    Entregado el 09 mar 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee) on Trust for Itself and the Otherborrower Secured Parties
    Transacciones
    • 09 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 21 jul 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    A supplemental borrower deed of charge supplemental to the borrower deed of charge dated 20 june 2001
    Creado el 15 ago 2003
    Entregado el 28 ago 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all of its interest in the charged additional mortgaged property. All its rights under the agreement and declaration of trust and deed of instruction and indemnity. All fixtures owned by it at the charged additional mortgaged property and its interest in any fixtures in its possession. Its interest in all benefits in respect of the insurances to the extent that they relate to the charged additional mortgaged property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as Secured Note Trustee
    Transacciones
    • 28 ago 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar")
    Creado el 20 jun 2001
    Entregado el 06 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as the Trustee Pursuant to Thesecured Note Trust Deed (The "Secured Note Trustee") on Trust for Itself and the Other Borrowersecured Parties
    Transacciones
    • 06 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 04 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BLSSP (PHC 31) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 sept 2013Fecha de disolución
    06 dic 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0