WORKSPACE 9 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWORKSPACE 9 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04106607
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WORKSPACE 9 LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra WORKSPACE 9 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Canterbury Court Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WORKSPACE 9 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GLE PROPERTY DEVELOPMENTS (KINGSTON) LIMITED15 dic 200015 dic 2000
    RBCO 348 LIMITED13 nov 200013 nov 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WORKSPACE 9 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WORKSPACE 9 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Chester House Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE a Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE el 01 nov 2016

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 25 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 oct 2015

    Estado de capital el 05 oct 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 oct 2014

    Estado de capital el 07 oct 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 oct 2013

    Estado de capital el 14 oct 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    4 páginasAA

    Cancelación total de la carga 4

    2 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    4 páginasAA

    Nombramiento de Mr Jameson Paul Hopkins como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Harry Platt como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Magenta House 85 Whitechapel Road London E1 1DU* el 04 ago 2011

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Harry Platt el 19 oct 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Graham Colin Clemett el 19 oct 2010

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 25 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Graham Colin Clement el 24 sept 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de WORKSPACE 9 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CARFORA, Carmelina
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Secretario
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    150287080001
    CLEMETT, Graham Colin
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Director
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    United KingdomBritish123744930001
    HOPKINS, Jameson Paul
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Director
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    United KingdomBritish79842180002
    BINNS, Adam
    15 Langhams Way
    Wargrave
    RG10 8AX Reading
    Berkshire
    Secretario
    15 Langhams Way
    Wargrave
    RG10 8AX Reading
    Berkshire
    British113638490001
    CHAPMAN, Paul Stephen
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    Secretario
    13 Southbourne
    Hayes
    BR2 7NJ Bromley
    Kent
    British1403010005
    MACDONALD, Iain Graham Ross
    172 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    Secretario
    172 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    British66669510002
    NOEL, Dawn
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    Secretario
    6 Cantley Road
    Hanwell
    W7 2BQ London
    British79021070001
    TAYLOR, Robert Mark
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    British43039830001
    WHALLEY, Amanda
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    Secretario
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    British124348320001
    RB SECRETARIAT LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Secretario designado corporativo
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006270001
    CARRAGHER, Madeleine
    17 Stadium Street
    Chelsea
    SW10 0PU London
    Director
    17 Stadium Street
    Chelsea
    SW10 0PU London
    British46150230001
    COMPTON, Colin Richard
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    Director
    Kingsland House Kingsland Lane
    Leavenheath
    CO6 4PD Colchester
    Essex
    British12075710001
    LARGE, Martin Gerald
    Legh Manor Farmhouse Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Sussex
    Director
    Legh Manor Farmhouse Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish44118740002
    MARPLES, James Patrick
    Churchfield
    All Saints Lane Sutton Courtenay
    OX14 4AG Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Churchfield
    All Saints Lane Sutton Courtenay
    OX14 4AG Abingdon
    Oxfordshire
    British80588240002
    PLATT, Harry
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    United Kingdom
    Director
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish41914500003
    RUSHTON, Christopher Arthur
    Copper Beaches
    Plaw Hatch Lane, Sharpthorne
    RH19 4JL East Grinstead
    West Sussex
    Director
    Copper Beaches
    Plaw Hatch Lane, Sharpthorne
    RH19 4JL East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritish44369580002
    TAYLOR, Robert Mark
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    British43039830001
    RB DIRECTORS ONE LIMITED
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    Director designado corporativo
    Beaufort House Tenth Floor
    15 St Botolph Street
    EC3A 7EE London
    900006260001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WORKSPACE 9 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Workspace 2 Limited
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    England
    06 abr 2016
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalEngland And Wales
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WORKSPACE 9 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 02 abr 2002
    Entregado el 09 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage kingsmill business park, chapel mill road, kingston upon thames, surrey l/h t/n SGL633096. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 25 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment of agreement for lease
    Creado el 25 sept 2001
    Entregado el 12 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company and/or gle property developments limited to the chargee
    Breve descripción
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement of the lease dated 02 february 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 12 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 27 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of development agreement
    Creado el 25 sept 2001
    Entregado el 12 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company and/or gle property developments limited to the chargee
    Breve descripción
    The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge absolutely all that the agreement dated 02 february 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 12 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 27 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 sept 2001
    Entregado el 12 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including the company's rights in an agreement dated 02 february 2001 for the grant of a 999 year lease of land of villiers road, kingston-upon-thames, surrey... Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transacciones
    • 12 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 27 feb 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0