WORKSPACE 9 LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WORKSPACE 9 LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04106607 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WORKSPACE 9 LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra WORKSPACE 9 LIMITED?
| Dirección de la sede social | Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WORKSPACE 9 LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GLE PROPERTY DEVELOPMENTS (KINGSTON) LIMITED | 15 dic 2000 | 15 dic 2000 |
| RBCO 348 LIMITED | 13 nov 2000 | 13 nov 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WORKSPACE 9 LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WORKSPACE 9 LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Chester House Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE a Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE el 01 nov 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 sept 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 sept 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 sept 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jameson Paul Hopkins como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Harry Platt como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 sept 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Magenta House 85 Whitechapel Road London E1 1DU* el 04 ago 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Harry Platt el 19 oct 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Graham Colin Clemett el 19 oct 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 25 sept 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Graham Colin Clement el 24 sept 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WORKSPACE 9 LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARFORA, Carmelina | Secretario | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | 150287080001 | |||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Director | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||
| HOPKINS, Jameson Paul | Director | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Canterbury Court England | United Kingdom | British | 79842180002 | |||||
| BINNS, Adam | Secretario | 15 Langhams Way Wargrave RG10 8AX Reading Berkshire | British | 113638490001 | ||||||
| CHAPMAN, Paul Stephen | Secretario | 13 Southbourne Hayes BR2 7NJ Bromley Kent | British | 1403010005 | ||||||
| MACDONALD, Iain Graham Ross | Secretario | 172 White Hill HP5 1AZ Chesham Buckinghamshire | British | 66669510002 | ||||||
| NOEL, Dawn | Secretario | 6 Cantley Road Hanwell W7 2BQ London | British | 79021070001 | ||||||
| TAYLOR, Robert Mark | Secretario | 15 Hollow Way Lane HP6 6DJ Amersham Buckinghamshire | British | 43039830001 | ||||||
| WHALLEY, Amanda | Secretario | 12 Merchant Court 61 Wapping Wall Wapping E1W 3SD London | British | 124348320001 | ||||||
| RB SECRETARIAT LIMITED | Secretario designado corporativo | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006270001 | |||||||
| CARRAGHER, Madeleine | Director | 17 Stadium Street Chelsea SW10 0PU London | British | 46150230001 | ||||||
| COMPTON, Colin Richard | Director | Kingsland House Kingsland Lane Leavenheath CO6 4PD Colchester Essex | British | 12075710001 | ||||||
| LARGE, Martin Gerald | Director | Legh Manor Farmhouse Cuckfield Road Ansty RH17 5AJ Haywards Heath West Sussex | United Kingdom | British | 44118740002 | |||||
| MARPLES, James Patrick | Director | Churchfield All Saints Lane Sutton Courtenay OX14 4AG Abingdon Oxfordshire | British | 80588240002 | ||||||
| PLATT, Harry | Director | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Chester House United Kingdom | United Kingdom | British | 41914500003 | |||||
| RUSHTON, Christopher Arthur | Director | Copper Beaches Plaw Hatch Lane, Sharpthorne RH19 4JL East Grinstead West Sussex | England | British | 44369580002 | |||||
| TAYLOR, Robert Mark | Director | 15 Hollow Way Lane HP6 6DJ Amersham Buckinghamshire | British | 43039830001 | ||||||
| RB DIRECTORS ONE LIMITED | Director designado corporativo | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006260001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WORKSPACE 9 LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workspace 2 Limited | 06 abr 2016 | Kennington Park 1-3 Brixton Road SW9 6DE London Chester House England | No | ||||
| |||||||
Naturaleza del control
| |||||||
¿Tiene WORKSPACE 9 LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creado el 02 abr 2002 Entregado el 09 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción By way of legal mortgage kingsmill business park, chapel mill road, kingston upon thames, surrey l/h t/n SGL633096. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment of agreement for lease | Creado el 25 sept 2001 Entregado el 12 oct 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies obligations and liabilities due or to become due from the company and/or gle property developments limited to the chargee | |
Breve descripción The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge all that the agreement of the lease dated 02 february 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment of development agreement | Creado el 25 sept 2001 Entregado el 12 oct 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies obligations and liabilities due or to become due from the company and/or gle property developments limited to the chargee | |
Breve descripción The company with full title guarantee assigns to the bank by way of charge absolutely all that the agreement dated 02 february 2001 and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 25 sept 2001 Entregado el 12 oct 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Including the company's rights in an agreement dated 02 february 2001 for the grant of a 999 year lease of land of villiers road, kingston-upon-thames, surrey... Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0