GRS PUBS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGRS PUBS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04111631
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GRS PUBS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra GRS PUBS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GRS PUBS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BANKSIDE PUBS LIMITED11 may 200711 may 2007
    BANKSIDE DEVELOPMENTS LIMITED03 may 200103 may 2001
    TATE TOWER LIMITED21 nov 200021 nov 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GRS PUBS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GRS PUBS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    18 páginasLIQ14

    Cese del nombramiento de Samual Edward Kennedy como director el 08 abr 2018

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de un director

    2 páginasTM01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 ago 2017

    32 páginasLIQ03

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    5 páginas4.20

    Domicilio social registrado cambiado de 31 Haverscroft Industrial Estate New Road Attleborough Norfolk NR17 1YE a Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 14 sept 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 11 ago 2016

    LRESEX

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 ene 2016

    Estado de capital el 13 ene 2016

    • Capital: GBP 8,405,766
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 dic 2014

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 ene 2015

    Estado de capital el 03 ene 2015

    • Capital: GBP 13,889,684
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 dic 2013

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 dic 2013

    Estado de capital el 03 dic 2013

    • Capital: GBP 13,889,684
    SH01

    Cuentas preparadas hasta el 30 dic 2012

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 25 dic 2011

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 26 dic 2010

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 oct 2010

    14 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 27 dic 2009

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alastair Ferguson como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Ian Robinson como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de William Buchanan como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Russell Cawtheray como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de GRS PUBS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse 92
    Director
    Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse 92
    United KingdomBritishNone51167890002
    CULVER, Justin Mark
    143 Andrewes House
    Barbican
    EC2Y 8BA London
    Secretario
    143 Andrewes House
    Barbican
    EC2Y 8BA London
    British83567650001
    DODWELL, John Christopher
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    Secretario
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    BritishCompany Director95741610001
    FERGUSON, Alastair William
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    Secretario
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    British146760260001
    LELLO, Graham
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    Secretario
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    South AfricanAccountant97505870001
    MCGOURTY, Paula Kim
    68 Standen Road
    Southfields
    SW18 5TG London
    Secretario
    68 Standen Road
    Southfields
    SW18 5TG London
    BritishChartered Accountant73364230001
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Secretario
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    British149837760001
    GD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Goodman Derrick
    6th Floor 90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    Secretario corporativo
    Goodman Derrick
    6th Floor 90 Fetter Lane
    EC4A 1PT London
    66216820001
    BUCHANAN, Jonathan Angus
    Unstead Manor
    Trunley Heath Road Bramley
    GU5 0BW Guildford
    Surrey
    Director
    Unstead Manor
    Trunley Heath Road Bramley
    GU5 0BW Guildford
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director121511400002
    BUCHANAN, William Arthur Neil
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishCa67066450003
    CAWTHERAY, Russell
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    Director
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    BritishDirector124176180001
    CROWTHER, Mark
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    Director
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    BritishDirector104967480001
    DODWELL, John Christopher
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    Director
    Aria House
    23 Craven Street
    WC2N 5NT London
    BritishCompany Director95741610001
    GRAY, Peter Francis
    1 Bradbourne Street
    SW6 3TF London
    Director
    1 Bradbourne Street
    SW6 3TF London
    United KingdomBritishCompany Director4637200001
    GUNDRY, Richard
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    Director
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Director107010490001
    KENNEDY, Samual Edward
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    Director
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    EnglandBritishDirector149343140001
    LELLO, Graham
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    Director
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    South AfricanAccountant97505870001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director57975730001
    SHARP, Kevan
    5 Mizen Close
    KT11 2RJ Cobham
    Surrey
    Director
    5 Mizen Close
    KT11 2RJ Cobham
    Surrey
    BritishConsultant82257500001
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Director
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishCompany Director149837760001
    WANFORD, Matthew
    Flat 1 Bridgport Place
    SE17 1HB Wapping
    Director
    Flat 1 Bridgport Place
    SE17 1HB Wapping
    BritishSolicitor88305120002
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Director
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritishDirector82667700001

    ¿Tiene GRS PUBS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of charge over shares
    Creado el 13 abr 2007
    Entregado el 30 abr 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed legal charge all of its present and future rights,title and interest in and to the scheduled securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 30 abr 2007Registro de un cargo (395)
    Supplemental legal charge
    Creado el 13 abr 2007
    Entregado el 30 abr 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H bull berkhamstead herts t/no HD329381,f/h cheshire cheese warrington cheshire t/no CH443388,f/h dock south shields t/no TY350973 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Securtiy Agent")
    Transacciones
    • 30 abr 2007Registro de un cargo (395)
    Supplemental legal charge
    Creado el 21 dic 2006
    Entregado el 28 dic 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H abinger arms guildford road abinger hammer dorking surrey t/no sy 648908,f/h alexandra 170 prsecott road fairfield liverpool t/no MS349200,f/h anchor london road bourne end hemel hempstead herts t/no HD329370 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agrent")
    Transacciones
    • 28 dic 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 30 nov 2006
    Entregado el 06 dic 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Anchor inn fore street chudleigh knighton f/h t/n DN318739 bell inn 180 drew street brixham f/h t/n DN313236 cheddar valley inn tusker street wells f/h t/n ST89453. For further details of property charged please refer to form 395. the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 06 dic 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 31 may 2006
    Entregado el 13 jun 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property k/a anchor inn fore street chudleigh knighton t/no DN318739, f/h property k/a bell inn 108 drew street brixham t/no DN313236, f/h property k/a cheddar valley inn tucker street wells t/no ST89453 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transacciones
    • 13 jun 2006Registro de un cargo (395)
    A security agreement
    Creado el 09 abr 2003
    Entregado el 19 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All estates or interest in any f/h or l/h property now owned by it, all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery on that property, and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the chargor in respect of that property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • London Town PLC
    Transacciones
    • 19 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 25 jun 2001
    Entregado el 30 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The freehold property known as 44 holland street & 47 hopton street london t/no: SGL340846. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 29 may 2001
    Entregado el 02 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 02 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 06 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene GRS PUBS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 sept 2018Fecha de disolución
    11 ago 2016Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Lyn L Vardy
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Profesional
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    David Christian Chubb
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0