BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04113691 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED?
Dirección de la sede social | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
BETT HOMES (EAST MIDLANDS) LIMITED | 22 nov 2004 | 22 nov 2004 |
KEEPCYCLE LIMITED | 24 nov 2000 | 24 nov 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 30 High Street Westerham Kent England and Wales TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP el 23 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Segunda presentación de AR01 previamente entregado a Companies House elaborado el 24 nov 2013 | 18 páginas | RP04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Jon William Mortimore como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neil Fitzsimmons el 01 nov 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147808310001 | |||||||
LEWIS, Colin Edward | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | British | Director | 59395180001 | ||||
SHARP, Giles Henry | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 194659450001 | ||||
GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | Director | 75350600002 | |||||
GANDHI, Devendra | Secretario | 50 Warlington Road CR7 7DE Thornton Heath Surrey | British | 75350600001 | ||||||
JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
MASON, Eddie Roy | Secretario | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Dundee | British | 606150007 | ||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 1 Martlesham AL7 2QF Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 72249480001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BEAZER, Anthony Hadyn | Director | 172b West Hill Putney SW15 3SL London | United Kingdom | British | Director | 91412650001 | ||||
BRODIE, Jonathan Ross | Director | Barn Cottage Moon Lane Dormansland RH7 6PD Lingfield Surrey | England | British | Company Director | 62279790001 | ||||
CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | Director | 154997530001 | ||||
CLARKE, Peter Courtenay | Director | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | Chartered Secretary | 78691990001 | |||||
DIPRE, John Vivian | Director | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 9018280015 | ||||
DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 35117250001 | ||||
FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69006050003 | ||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||
GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | Director | 84605410002 | ||||
GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | Accountant | 75350600002 | ||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Cro | 137285750001 | ||||
MCNEIL, Phillip | Director | 14 Lock House Lane Earswick YO32 9FT York North Yorkshire | British | Managing Director | 103066930001 | |||||
METLISS, Cyril | Director | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||
MORTIMORE, Jon William | Director | High Street Westerham TN16 1RG Kent 30 England And Wales | United Kingdom | British | Cfo | 207729000002 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Tiene BETT HOMES (YORKSHIRE) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 09 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 14 sept 2007 Entregado el 21 sept 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0