TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04126418 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
- Seguros de vida (65110) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street EC2V 7BG London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TILNEY GROUP LIMITED | 12 dic 2016 | 12 dic 2016 |
| YORKSHIRE INVESTMENT GROUP LIMITED | 15 dic 2000 | 15 dic 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 12 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 21 sept 2022 | 13 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY a C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG el 05 jul 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Gavin Raymond White el 14 jun 2022 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Martin Baddeley el 14 jun 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Observatory Western Road Bracknell RG12 1TL United Kingdom a C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY el 01 oct 2021 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Deborah Ann Saunders como secretario el 01 sept 2021 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gavin Raymond White como secretario el 01 sept 2021 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicola Claire Mitford-Slade como director el 18 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Woodhouse como director el 18 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Nicola Claire Mitford-Slade como director el 22 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Donald William Sherret Reid como director el 22 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rehana Hasan como secretario el 22 oct 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Deborah Ann Saunders como secretario el 22 oct 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ England a 25 Moorgate London EC2R 6AY | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Modification des détails de Uk Wealth Management Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE, Gavin Raymond | Secretario | Gresham Street EC2V 7BG London 45 United Kingdom | 287111660001 | |||||||
| BADDELEY, Andrew Martin | Director | Gresham Street EC2V 7BG London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 82469460001 | |||||
| BELLAMY, Martin William | Secretario | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | 173987280001 | |||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secretario | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | 197499510001 | |||||||
| HASAN, Rehana | Secretario | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | 217675490001 | |||||||
| JOHNSTON, Carol Ann | Secretario | 9i Calles Las Palmeras Urb Vista Laguna 11312 Torreguadiaro Cadiz Spain | British | 52538020003 | ||||||
| NICHOLS, Sarah | Secretario | Lisbon Square LS1 4LY Leeds 8 West Yorkshire | British | 157133400001 | ||||||
| PEACOCK, Natasha Valerie | Secretario | Pear Tree Drive SK15 2PY Stalybridge 7 Cheshire | British | 129803720001 | ||||||
| SAUNDERS, Deborah Ann | Secretario | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | 276008310001 | |||||||
| BRADSHAW, Phillip Gordon | Director | Springfield Farm Hardwick Road East Hardwick WF8 3DL Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 26428400002 | |||||
| BUSSEY, Michael Adrian | Director | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | British | 52554700003 | |||||
| CHAPMAN, Andrew | Director | Ask House 88 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 39777190002 | |||||
| COLEMAN, Lynn Rose | Director | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | British | 149721950001 | |||||
| CRESWELL-TURNER, Miles Marius | Director | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | England | British | 160087860001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Director | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 146956760001 | |||||
| DOWNING, Wadham St. John | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 203301710001 | |||||
| DUFTON, Jeremy Jon | Director | 1 Long Meadow High Ackworth WF7 7EA Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 56706650001 | |||||
| FLETCHER, Alfred Olding | Director | 154a Western Way Darras Hall NE20 9LY Pontelant Northumberland | England | British | 226590003 | |||||
| FRASER, Thomas Aird | Director | Flat 3 20 Lower Sloane Street SW1W 8BJ London | Australian | 74112910002 | ||||||
| HAINSWORTH BREAR, Timothy Austin | Director | Wyndorf 11a Fairway Tranmere Park Guiseley LS20 8JT Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 110677380001 | |||||
| HALL, Peter Lindop | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 212005290001 | |||||
| HERON, Hugh | Director | 114 Carleton Road WF8 3NQ Pontefract West Yorkshire | England | British | 26428410003 | |||||
| HOGG, Andrew | Director | 6 Tranfield Gardens Guiseley LS20 8PZ Leeds West Yorkshire | British | 63356910003 | ||||||
| JOHNSTON, Carol Ann | Director | Brindley House Valley Road Killamarsh S21 1JB Sheffield | British | 52538020002 | ||||||
| JONES, Peter Francis | Director | 15 Wigton Park Close LS17 8UH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 33965180002 | |||||
| MITFORD-SLADE, Nicola Claire | Director | Moorgate EC2R 6AY London 25 England | United Kingdom | British | 276051890001 | |||||
| MULLORD, Kathleen Francis | Director | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | United Kingdom | South African | 160087800001 | |||||
| POLIN, Jonathan Charles | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | Scotland | British | 97840060003 | |||||
| PORTEOUS, John Robert | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 166212270001 | |||||
| REID, Donald William Sherret | Director | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | England | British | 212004930001 | |||||
| SAWYER, Gareth Matthew | Director | 5 Chelmsford Road HG1 5NA Harrogate | United Kingdom | British | 46468670003 | |||||
| SINCLAIR, Richard Harris | Director | Ropergate House 43 Ropergate Pontefract WF8 1JY West Yorkshire | England | British | 204668540001 | |||||
| TAGLIABUE, Alfio | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 England | United Kingdom | Italian | 76352220004 | |||||
| WOODHOUSE, Christopher | Director | Chesterfield Gardens W1J 5BQ London 6 England England | England | British | 238888480001 | |||||
| WRIGHT, Paul Vernon | Director | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 137936580001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uk Wealth Management Limited | 06 abr 2016 | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 04 jun 2015 Entregado el 11 jun 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creado el 22 oct 2002 Entregado el 29 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Policy no RNF00072345A for £200,000 over life of phillip gordon bradshaw with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creado el 22 oct 2002 Entregado el 29 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Policy no RNF0072346A for £200,000 over life of hugh heron with all bonuses and benefits thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creado el 22 oct 2002 Entregado el 29 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Policy no RNF0072342A for £200,000 over life of andrew hogg with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Assignment of keyman life policy | Creado el 22 oct 2002 Entregado el 29 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Policy no RNF0072344A for £200,000 over life of peter francis jones with all sums,bonuses and benefits thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 02 oct 2002 Entregado el 17 oct 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Licence to assign | Creado el 27 nov 2001 Entregado el 28 nov 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and media works corporation communications LTD to the chargee pursuant to the licence to assign | |
Breve descripción The sum of £10,350.00 plus vat the account in which the sum is deposited and all sums from time to time standing to the credit of the account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture deed | Creado el 28 feb 2001 Entregado el 06 mar 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene TILNEY BESTINVEST GROUP LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0