GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04127837 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED?
Dirección de la sede social | 7th Floor Exchange House 12 Exchange Square EC2A 2NY London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Stuart Blackett el 14 mar 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Ms Victoria Jill Bell como director el 15 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Charles Wilkinson como director el 15 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Lisa Melanie Sunner como director el 30 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stuart Blackett como director el 30 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Cyril Francis Johnson como director el 30 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher John Hitchen como director el 30 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Matthew Teasdale como director el 30 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2Nd Floor Camomile Court 23 Camomile Street London EC3A 7LL a 7Th Floor Exchange House 12 Exchange Square London EC2A 2NY el 27 feb 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Veronica Warner como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Matthew Teasdale el 08 mar 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Cyril Francis Johnson el 11 dic 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL, Victoria Jill | Director | Exchange House 12 Exchange Square EC2A 2NY London 7th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 198661950001 | ||||
BLACKETT, Stuart | Director | Exchange House 12 Exchange Square EC2A 2NY London 7th Floor | United Kingdom | British | Financial Controller | 197266270001 | ||||
HITCHEN, Christopher John | Director | Exchange House 12 Exchange Square EC2A 2NY London 7th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 61207060003 | ||||
SUNNER, Lisa Melanie | Director | Exchange House 12 Exchange Square EC2A 2NY London 7th Floor United Kingdom | England | British | Company Secretary | 178242920001 | ||||
FAIRCLOUGH, Susan | Secretario | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 2nd Floor United Kingdom | British | Director | 36381560010 | |||||
ROBSON SKEETE, Gail | Secretario | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | Accountant | 66939460001 | |||||
WARNER, Veronica | Secretario | Floor Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 2nd United Kingdom | 169548510001 | |||||||
MOURANT & CO CAPITAL SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 8th Floor 68 King William Street EC4N 7DZ London | 108845150002 | |||||||
BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Director | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | Company Director | 34251500001 | ||||
BIBRING, Michael Albert | Director | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | Solicitor | 9320160002 | ||||
BLURTON, Andrew Francis | Director | Old Cedar House Guildford Road GU6 8LT Cranleigh Surrey | England | British | Company Director | 53724380001 | ||||
BRADLEY, Nigel Charles | Director | 64 Owl Way Hartford PE29 1YZ Huntingdon Cambridgeshire | British | Banker | 92837270001 | |||||
CHAPMAN, Julia Anne Jennifer | Director | Vincent Hall Becquet Vincent Trinity JE3 5FG Jersey | United Kingdom | British | Solicitor | 51408760001 | ||||
ESSEX CATER, Gareth | Director | 11 Duhamel Place St Helier JE2 4TP Jersey | British | Corporate Services Manager | 91555540001 | |||||
FAIRCLOUGH, Susan | Director | Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 2nd Floor United Kingdom | British | Director | 36381560010 | |||||
HARRISON, John William | Director | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | Director | 69263980002 | ||||
JOHNSON, Cyril Francis | Director | Exchange House 12 Exchange Square EC2A 2NY London 7th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 100691960002 | ||||
KAIRIS, Stephen Charles | Director | 25 Stradbroke Grove IG9 5PD Buckhurst Hill Essex | British | Director | 97841890001 | |||||
REVILLE, Brendan Dominick | Director | 5 Houblon Road TW10 6DB Richmond Surrey | British | Director | 81295520002 | |||||
SHASHOU, Joseph Saleem | Director | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | Property Developer | 51723030002 | ||||
SINGH, Jagtar | Director | 163 Hempstead Road WD17 3HF Watford Hertfordshire | British | Director | 75421990001 | |||||
TEASDALE, David Matthew | Director | Floor Camomile Court 23 Camomile Street EC3A 7LL London 2nd United Kingdom | United Kingdom | British | Director Of Finance And Corporate Services | 148034980001 | ||||
WALKER, Jonathan Clemson | Director | 55 Clerkenwell Close EC1R 0ER London | British | Solictor | 72608030001 | |||||
WILKINSON, Timothy Charles | Director | Exchange House 12 Exchange Square EC2A 2NY London 7th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Accountant | 148032830001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marble Arch Tower General Partner Limited | 06 abr 2016 | Exchange House 12 Exchange Square EC2A 2NY London 7th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene GRENVILLE NOMINEES NO.2 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 03 jun 2003 Entregado el 16 jun 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción L/H property k/a the odeon cinema marble arch 2 to 10 (even) edgware road 53 to 59 (odd) bryanston street and 5 to 9 (all) marble arch t/no NGL794490. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 19 mar 2001 Entregado el 04 abr 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All liabilities of the obligors owed or expressed to be owed to the beneficiaries under or in connection with the finance documents | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0