ELY CARE HOME LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ELY CARE HOME LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04131023 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ELY CARE HOME LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ELY CARE HOME LIMITED?
Dirección de la sede social | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ELY CARE HOME LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ELY NURSING HOME LIMITED | 27 dic 2000 | 27 dic 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ELY CARE HOME LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ELY CARE HOME LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 24 jul 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Midmer como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 sept 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Smith como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kamma Foulkes como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director William James Buchan el 27 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Richard Neil Midmer el 27 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Kamma Foulkes el 27 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario William David Mcleish el 27 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ELY CARE HOME LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR, Stephen Jonathan | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
ALFLATT, John Neal | Secretario | 3 Goldings Lane Waterford SG14 2PT Hertford Hertfordshire | British | 86320800001 | ||||||
KIME, Sean Thomas | Secretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305550001 | |||||||
MCLEISH, William David | Secretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
RUTTER, Christopher | Secretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
SLACK, Michael Stephen | Secretario | 239 Greenmount Lane BL1 5JB Bolton Lancashire | British | 9265180001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BOLOT, Timothy James | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BUCHAN, William James | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
COLVIN, William | Director | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
FLAHERTY, James Paul | Director | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | Director | 100530310001 | |||||
FOULKES, Kamma | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 111188390002 | ||||
GOSLING, Mark David | Director | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | Director | 66801660002 | |||||
HANDLEY, David Michael | Director | 13 Shillingstone Close Harwood BL2 3PD Bolton Lancashire | United Kingdom | British | Chartered Accountants | 52899270001 | ||||
JAP, Chee Miau | Director | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | Director | 101200680001 | ||||
LOCK, Jason David | Director | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 110640170001 | ||||
MURPHY, John | Director | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | Director | 26177180004 | ||||
PATEL, Mahesh Shivabhai | Director | 29 The Avenue HA5 5BN Pinner Middlesex | United Kingdom | British | Company Director | 80756410001 | ||||
RUTTER, Christopher | Director | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
SCOTT, Philip Henry | Director | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | Director | 174231320001 | ||||
SIZER, Graham Kevin | Director | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | Director | 77274540003 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Director | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Director | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
STOREY, John | Director | 93 Dacre Park Blackheath SE13 5BX London | British | Director | 60123860002 |
¿Tiene ELY CARE HOME LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 05 jul 2002 Entregado el 19 jul 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a land on the west side of lynn road ely cambridge CB2 1SD t/no CB232848. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 05 jul 2002 Entregado el 18 jul 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0