ELY CARE HOME LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaELY CARE HOME LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04131023
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ELY CARE HOME LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ELY CARE HOME LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ELY CARE HOME LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ELY NURSING HOME LIMITED27 dic 200027 dic 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ELY CARE HOME LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ELY CARE HOME LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 24 jul 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 dic 2011

    Estado de capital el 29 dic 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Midmer como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 sept 2009

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Smith como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kamma Foulkes como director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director William James Buchan el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Richard Neil Midmer el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Kamma Foulkes el 27 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario William David Mcleish el 27 oct 2009

    1 páginasCH03

    ¿Quiénes son los directivos de ELY CARE HOME LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector163496070001
    ALFLATT, John Neal
    3 Goldings Lane
    Waterford
    SG14 2PT Hertford
    Hertfordshire
    Secretario
    3 Goldings Lane
    Waterford
    SG14 2PT Hertford
    Hertfordshire
    British86320800001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Secretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305550001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Secretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    SLACK, Michael Stephen
    239 Greenmount Lane
    BL1 5JB Bolton
    Lancashire
    Secretario
    239 Greenmount Lane
    BL1 5JB Bolton
    Lancashire
    British9265180001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Director
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Director
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    AmericanDirector100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Director
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    BritishDirector66801660002
    HANDLEY, David Michael
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    Director
    13 Shillingstone Close
    Harwood
    BL2 3PD Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritishChartered Accountants52899270001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Director
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporeanDirector101200680001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Director
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Director
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritishDirector26177180004
    PATEL, Mahesh Shivabhai
    29 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    Director
    29 The Avenue
    HA5 5BN Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director80756410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Director
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritishDirector174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Director
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritishDirector77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Director
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritishDirector147997950001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Director
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    BritishDirector60123860002

    ¿Tiene ELY CARE HOME LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 05 jul 2002
    Entregado el 19 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land on the west side of lynn road ely cambridge CB2 1SD t/no CB232848. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 jul 2002
    Entregado el 18 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0