CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED

CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04132389
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    Bedfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) PLC01 jun 200301 jun 2003
    L.I. HOLDINGS (UK) PLC12 dic 200112 dic 2001
    LI HOLDINGS (UK) LIMITED26 feb 200126 feb 2001
    ALNERY NO. 2125 LIMITED29 dic 200029 dic 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 dic 2011

    8 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom

    1 páginasAD02

    Déclaration annuelle établie au 29 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2012

    Estado de capital el 06 ene 2012

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    legacy

    3 páginasMG02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    10 páginasAA

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom

    1 páginasAD02

    Déclaration annuelle établie au 29 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    9 páginasAA

    Certificado de re-registro de Compañía Pública Limitada a Privada

    1 páginasCERT10

    Re-registro del Memorándum y Estatutos

    9 páginasMAR

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de re-registro

    RES02

    Re-registro de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada

    2 páginasRR02

    Déclaration annuelle établie au 29 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Andrew Burchall el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Rebecca Jane Watson el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Rebecca Jane Watson el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    10 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Other133821050001
    BURCHALL, Andrew Jeremy
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish69904570002
    WATSON, Rebecca Jane
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    800 The Boulevard
    Capability Green
    LU1 3BA Luton
    C/O Impellam Group Plc
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish70686070002
    OSBORNE, Philip Thomas
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    Secretario
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    British76955710002
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Secretario
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Secretario
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    British57975730001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secretario designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BRADFORD, Richard James
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    Director
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    United KingdomBritish72452740004
    CHOLERTON, John David
    3 Bryanston Avenue
    Whitton
    TW2 6HP Twickenham
    Middlesex
    Director
    3 Bryanston Avenue
    Whitton
    TW2 6HP Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish9497220001
    COATES, Jeremy William
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    Director
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish58806030001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    Director
    Bagwell Lane
    RG29 1JG Odiham
    Green Hill
    Hampshire
    EnglandBritish266121440001
    LAWRIE, Stuart
    Magpie Cottage
    Retford Road
    S81 8ER Blyth
    Nottinghamshire
    Director
    Magpie Cottage
    Retford Road
    S81 8ER Blyth
    Nottinghamshire
    British84516540001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Director
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    EnglandBritish38346120001
    PUGH, Ian Russel
    Albury Lodge Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    Director
    Albury Lodge Warren Drive
    Kingswood
    KT20 6PZ Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritish61327530003
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish57975730001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001
    SOUTHTOWN LIMITED
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    Director corporativo
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    70598540001

    ¿Tiene CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 06 may 2008
    Entregado el 23 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Trusgtee (C.I.) Limited (the "Security Trustee")
    Transacciones
    • 23 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 11 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 06 may 2008
    Entregado el 17 may 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 may 2008Registro de un cargo (395)
    A deed of charge and memorandum of deposit between the depositors and the bank of nova scotia as agent and security trustee (the"security trustee") for the secured parties (as defined)
    Creado el 12 mar 2001
    Entregado el 30 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations of the depositors to the chargee under or in respect of the credit agreement the guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each depositor under the deed (in each case whether in respect of principal interest fees taxes costs expenses or indemnities and whether present or future or actual or contingent) all terms as defined
    Breve descripción
    All the undertaking and all the assets rights income goodwill of the chargor both present and future see the mortgage charge document or full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia as Agent and Security Trustee for the Lenders
    Transacciones
    • 30 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of floating charge
    Creado el 01 mar 2001
    Entregado el 20 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or inrespect of the credit agreement the guarantee and other loan documents (all as defined)
    Breve descripción
    Floating charge all the undertaking and all the assets rights income and goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 20 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0