CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04132389 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton Bedfordshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) PLC | 01 jun 2003 | 01 jun 2003 |
| L.I. HOLDINGS (UK) PLC | 12 dic 2001 | 12 dic 2001 |
| LI HOLDINGS (UK) LIMITED | 26 feb 2001 | 26 feb 2001 |
| ALNERY NO. 2125 LIMITED | 29 dic 2000 | 29 dic 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 dic 2011 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 10 páginas | AA | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF United Kingdom | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Certificado de re-registro de Compañía Pública Limitada a Privada | 1 páginas | CERT10 | ||||||||||
Re-registro del Memorándum y Estatutos | 9 páginas | MAR | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Re-registro de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada | 2 páginas | RR02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Andrew Burchall el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Rebecca Jane Watson el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Rebecca Jane Watson el 01 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 10 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 353 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATSON, Rebecca Jane | Secretario | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | Other | 133821050001 | ||||||
| BURCHALL, Andrew Jeremy | Director | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 69904570002 | |||||
| WATSON, Rebecca Jane | Director | 800 The Boulevard Capability Green LU1 3BA Luton C/O Impellam Group Plc Bedfordshire United Kingdom | England | British | 70686070002 | |||||
| OSBORNE, Philip Thomas | Secretario | 1715 Bella Vista PO BOX 1764 FOREIGN Belize City Belize | British | 76955710002 | ||||||
| PENNINGTON, David Ian | Secretario | Ferndene Applelands Close Boundstone GU10 4TL Farnham Surrey | British | 38346120001 | ||||||
| ROBINSON, Ian George | Secretario | 74 Brookmans Avenue Brookmans Park AL9 7QQ Hatfield Hertfordshire | British | 57975730001 | ||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Secretario designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| BRADFORD, Richard James | Director | Holcombe House Olney Road MK46 5BX Emberton Buckinghamshire Bucks | United Kingdom | British | 72452740004 | |||||
| CHOLERTON, John David | Director | 3 Bryanston Avenue Whitton TW2 6HP Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 9497220001 | |||||
| COATES, Jeremy William | Director | 62 The Grove MK40 3JN Bedford Bedfordshire | England | British | 58806030001 | |||||
| DOYLE, Desmond Mark Christopher | Director | Bagwell Lane RG29 1JG Odiham Green Hill Hampshire | England | British | 266121440001 | |||||
| LAWRIE, Stuart | Director | Magpie Cottage Retford Road S81 8ER Blyth Nottinghamshire | British | 84516540001 | ||||||
| PENNINGTON, David Ian | Director | Ferndene Applelands Close Boundstone GU10 4TL Farnham Surrey | England | British | 38346120001 | |||||
| PUGH, Ian Russel | Director | Albury Lodge Warren Drive Kingswood KT20 6PZ Tadworth Surrey | United Kingdom | British | 61327530003 | |||||
| ROBINSON, Ian George | Director | 74 Brookmans Avenue Brookmans Park AL9 7QQ Hatfield Hertfordshire | England | British | 57975730001 | |||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Director designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED | Director designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002910001 | |||||||
| SOUTHTOWN LIMITED | Director corporativo | Craigmuir Chambers PO BOX 71 Roadtown Tortola Br Virgin Islands | 70598540001 |
¿Tiene CARLISLE CLEANING SERVICES HOLDINGS (UK) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 06 may 2008 Entregado el 23 may 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the chargee or to any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee & debenture | Creado el 06 may 2008 Entregado el 17 may 2008 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from impellam group PLC, the original security obligors and any person which grants a security interest to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A deed of charge and memorandum of deposit between the depositors and the bank of nova scotia as agent and security trustee (the"security trustee") for the secured parties (as defined) | Creado el 12 mar 2001 Entregado el 30 mar 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All obligations of the depositors to the chargee under or in respect of the credit agreement the guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each depositor under the deed (in each case whether in respect of principal interest fees taxes costs expenses or indemnities and whether present or future or actual or contingent) all terms as defined | |
Breve descripción All the undertaking and all the assets rights income goodwill of the chargor both present and future see the mortgage charge document or full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A deed of floating charge | Creado el 01 mar 2001 Entregado el 20 mar 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or inrespect of the credit agreement the guarantee and other loan documents (all as defined) | |
Breve descripción Floating charge all the undertaking and all the assets rights income and goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0