SPICER HALLFIELD LIMITED

SPICER HALLFIELD LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSPICER HALLFIELD LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04132397
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SPICER HALLFIELD LIMITED?

    • (2123) /
    • (2223) /
    • (2225) /

    ¿Dónde se encuentra SPICER HALLFIELD LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPICER HALLFIELD LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DECORPRINT LIMITED11 abr 200111 abr 2001
    ST. REGIS PROPERTIES LIMITED06 feb 200106 feb 2001
    ALNERY NO.2111 LIMITED29 dic 200029 dic 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SPICER HALLFIELD LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2007

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SPICER HALLFIELD LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPICER HALLFIELD LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    13 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2015

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 mar 2015

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 08 dic 2014

    14 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    19 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2014

    15 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2014

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 mar 2014

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2013

    13 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 mar 2013

    10 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2012

    17 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 25 sept 2012

    5 páginas4.68

    Informe de progreso del administrador hasta 21 sept 2011

    24 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    23 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 abr 2011

    20 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 oct 2010

    20 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginas2.31B

    Domicilio social registrado cambiado de * 11 St. James's Square Manchester M2 6DN* el 28 jun 2010

    2 páginasAD01

    Informe de progreso del administrador hasta 02 abr 2010

    17 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 02 oct 2009

    16 páginas2.24B

    ¿Quiénes son los directivos de SPICER HALLFIELD LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMITH, Michael John
    Haddenham Hall
    Haddenham
    HP17 8AB Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Haddenham Hall
    Haddenham
    HP17 8AB Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish67300010001
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Secretario
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    British53026290001
    STEELE, Anne
    25 The Avenue
    Chiswick
    W4 1HA London
    Secretario
    25 The Avenue
    Chiswick
    W4 1HA London
    British77624110001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secretario designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BOYES TURNER SECRETARIES LIMITED
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Secretario corporativo
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    74407280002
    BUTTFIELD, David Frank
    Mill Meadow Mill Lane
    HP7 0EH Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    Mill Meadow Mill Lane
    HP7 0EH Amersham
    Buckinghamshire
    British37624090002
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    Cornwall Grove
    Chiswick
    W4 2LB London
    31
    Director
    Cornwall Grove
    Chiswick
    W4 2LB London
    31
    United KingdomBritish53026290002
    CHEVIS, Andrew William
    25 Delapre Drive
    OX16 3WP Banbury
    Oxfordshire
    Director
    25 Delapre Drive
    OX16 3WP Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish123143470001
    COATES, Donald William
    208 Redland Road
    Redland
    BS6 6YP Bristol
    Director
    208 Redland Road
    Redland
    BS6 6YP Bristol
    British73109880001
    DANCER, Terence
    23 Woodlands Avenue
    HP4 2JH Berkhamsted
    Director
    23 Woodlands Avenue
    HP4 2JH Berkhamsted
    British87713520001
    EVANS, Richard Arthur
    The Mallows Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    Director
    The Mallows Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    British58408910002
    HESKIN, Michael Thomas
    Rosendale 1 The Drive
    Bartlemy Road
    RG14 6JY Newbury
    Berkshire
    Director
    Rosendale 1 The Drive
    Bartlemy Road
    RG14 6JY Newbury
    Berkshire
    British45604960001
    HURRELL, Graham Anthony
    6 Ferndale Close
    Snailwell Road
    CB8 7DZ Newmarket
    Suffolk
    Director
    6 Ferndale Close
    Snailwell Road
    CB8 7DZ Newmarket
    Suffolk
    British79221500001
    MORRIS, Gavin Mathew
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    Director
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    EnglandBritish16228990001
    NICHOLSON, Simon William
    8 Paddock Drive
    Bramley
    S66 3ZE Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    8 Paddock Drive
    Bramley
    S66 3ZE Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritish28176890002
    STRATTON, Ogilvie Alexander
    Lot 2
    Funchal 8600
    FOREIGN Lagos
    Portugal
    Director
    Lot 2
    Funchal 8600
    FOREIGN Lagos
    Portugal
    British12279520002
    THORNE, Anthony David
    24 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Director
    24 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish40130640001
    TREVETHICK, Jeremy Richard
    23 Beauchamp Road
    KT8 0PA East Molesey
    Surrey
    Director
    23 Beauchamp Road
    KT8 0PA East Molesey
    Surrey
    EnglandBritish23975250001
    TURNEY, Jacqueline Anne
    73 Savernake Road
    HP19 9XP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    73 Savernake Road
    HP19 9XP Aylesbury
    Buckinghamshire
    British87706410001
    WILLIAMS, John Peter
    30 Egerton Crescent
    SW3 2EB London
    Director
    30 Egerton Crescent
    SW3 2EB London
    United KingdomBritish707720002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    ¿Tiene SPICER HALLFIELD LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 10 abr 2008
    Entregado el 15 abr 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2008Registro de un cargo (395)
    Fixed and floating charge
    Creado el 30 jun 2005
    Entregado el 02 jul 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 02 jul 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 13 feb 2003
    Entregado el 05 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Venture Finance PLC
    Transacciones
    • 05 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 16 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 feb 2003
    Entregado el 22 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • D S Smith PLC
    Transacciones
    • 22 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 feb 2003
    Entregado el 18 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SPICER HALLFIELD LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    03 abr 2009Inicio de la administración
    26 sept 2011Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Phillip Francis Duffy
    11 St James Square
    M2 6WH Manchester
    Profesional
    11 St James Square
    M2 6WH Manchester
    David John Whitehouse
    11 St James Square
    M2 6WH Manchester
    Profesional
    11 St James Square
    M2 6WH Manchester
    2
    FechaTipo
    11 may 2016Fecha de disolución
    26 sept 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David John Whitehouse
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Profesional
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Phillip Francis Duffy
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Profesional
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Profesional
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0