PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED

PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04132575
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    • Otra venta al por menor no en tiendas, puestos o mercados (47990) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Alquiler y arrendamiento de otras máquinas, equipo y bienes tangibles n.c.p. (77390) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LAW 2251 LIMITED29 dic 200029 dic 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cese del nombramiento de Mark Peter Evans como secretario el 24 may 2018

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Mark Peter Evans como director el 24 may 2018

    1 páginasTM01

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    22 páginasAM23

    Informe de progreso del administrador

    28 páginasAM10

    Declaración de la propuesta del administrador

    40 páginasAM03

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    19 páginas2.16B

    Domicilio social registrado cambiado de Unit 4 Boundary Court Willow Farm Business Park Castle Donington Derbyshire DE74 2UD a Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 30 mar 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    29 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 09 dic 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 15

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 09 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 feb 2016

    Estado de capital el 03 feb 2016

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 mar 2015

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ene 2015

    Estado de capital el 12 ene 2015

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Cese del nombramiento de John Pinkney como director el 25 mar 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Wayne Homes como director el 25 mar 2014

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Vernon Bradley como director el 25 mar 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 mar 2014

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 ene 2014

    Estado de capital el 15 ene 2014

    • Capital: GBP 126,250
    SH01

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 mar 2013

    17 páginasAA

    Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 mar 2012

    20 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    legacy

    6 páginasMG01

    ¿Quiénes son los directivos de PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ECCLESHALL, Christopher James
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Director
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    EnglandBritish100000660001
    EVANS, Mark Peter
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Secretario
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    British78582200002
    FREARSON, Richard
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    Secretario
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    British50961700001
    EVERSECRETARY LIMITED
    1 Royal Standard Place
    NG1 6FZ Nottingham
    Secretario corporativo
    1 Royal Standard Place
    NG1 6FZ Nottingham
    60471940015
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretario corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    61729550001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretario designado corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900018860001
    BRADLEY, Stephen Vernon
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Director
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish38805680002
    BRAMHALL, Darren
    Unit 9b
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UB Castle Donnington
    Derbyshire
    Director
    Unit 9b
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UB Castle Donnington
    Derbyshire
    United KingdomBritish139463440001
    BRAMHILL, Darren
    119 Park Lane
    DE74 2JG Castle Donington
    Derbyshire
    Director
    119 Park Lane
    DE74 2JG Castle Donington
    Derbyshire
    United KingdomBritish117298110001
    EVANS, Mark Peter
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    Director
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    EnglandBritish78582200002
    FREARSON, Richard
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    Director
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    British50961700001
    HOMES, David Wayne
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Director
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154849800001
    PINKNEY, John
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    Director
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154856180001
    RATCLIFFE, Eric George
    16 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    16 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish32530880003
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Director designado corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008150001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Director designado corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    09 dic 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge over sub-hire agreements
    Creado el 15 oct 2012
    Entregado el 23 oct 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The secured property, being- all right title interest and benefit in and to the sub-hire agreements see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 23 oct 2012Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 01 may 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    Chattels mortgage
    Creado el 19 nov 2004
    Entregado el 20 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery. 32FT x 10FT special jack leg unit. Fleet no:ccns-102 s/no 105/3/D531. 32FT x 10FT special jack leg unit. Fleet no: ccns-103 s/no 105/3/D532.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment (UK) Limited
    Transacciones
    • 20 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattels mortgage
    Creado el 19 feb 2004
    Entregado el 20 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Jack leg office/mess cabin units - s/nos 3/8062, 3/8063, s/8060, 3/8244, s/8692, 3/8957, 3/9056, 3/9070, 3/9101, 3/8982, N576, N594, N662, 3/8942. pallet racking s/no:B0051. Tiger hoist s/no's 777432-777437.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 20 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 12 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 18 dic 2003
    Entregado el 19 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule such as welding stands and frames with dustribution boards and accessories. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 19 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 08 oct 2003
    Entregado el 09 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    50 mastertig 350 mls welding machines,ser/nos 1108570,1108571,1108572 with all chattels plant machinery and things thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment (UK) Limited
    Transacciones
    • 09 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 24 sept 2003
    Entregado el 25 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule being isuzu tf mega 2.5 tdi D. cab 4X4, chassis no. JAATFS54H27103683 pallet racking, s/no. D0336.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 25 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 12 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 18 jun 2003
    Entregado el 20 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery 50 x mastertig 3500MLS welding machines serial numbers: 1096417, 1096418, 1097840 or any part thereof for further details of the property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 20 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 05 jun 2003
    Entregado el 06 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things or any part thereof:- 53 mastertig 3500MLS welding machines s/nos, 1073780, 1079468, 992661, 1065190, 1065191, for further details of chattels charged with serial numbers please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 06 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 28 may 2003
    Entregado el 29 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 29 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 14 mar 2003
    Entregado el 15 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto and the copy invoices attached hereto or any part thereof, schedule: vauxhall omega cdx V6, chassis no; WOLOVBM6911098696.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 15 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 11 feb 2003
    Entregado el 12 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    William hackett chains limited invoice numbers: op/0017699, OP0018057, OP0018460, OP0018520, OP0018020, hessle fork trucks limited invoice number 111756. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 12 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 05 feb 2003
    Entregado el 06 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the copy invoices attached to the form 395 or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 06 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 03 sept 2002
    Entregado el 03 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Vauxhall frontera 3.2I vg estate,reg/no NY02 uaw with all plant machinery and equipment thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 03 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creado el 28 mar 2002
    Entregado el 28 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    2001 robin AR4001 digi multimeter - 5904. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 28 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge (all assets)
    Creado el 14 ago 2001
    Entregado el 16 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Breve descripción
    (I) all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts including associated rights relating thereto and (ii) all amounts of indebtedness due on any account whatsoever, all goodwill and uncalled capital, all patents and patent applications. The floating charge over the remainder of the underatking and all propery rights and assets whatsoever and wheresoever, both present and future including the company's stock in trade and its uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 16 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 jun 2001
    Entregado el 12 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 12 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    06 mar 2017Inicio de la administración
    09 mar 2018Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0