STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04132862 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED?
Dirección de la sede social | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
IMCO (92001) LIMITED | 29 dic 2000 | 29 dic 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2015 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Colin Edward Lewis el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Giles Henry Sharp el 22 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 22 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG a Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP el 23 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Jon William Mortimore como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giles Sharp como director el 23 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Fitzsimmons como director el 12 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Joanne Elizabeth Massey el 15 dic 2014 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Colls como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Catchpole como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Jon William Mortimore como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Giles Asker como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 abr 2013 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 11 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147807750001 | |||||||
LEWIS, Colin Edward | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | British | Director | 59395180001 | ||||
SHARP, Giles Henry | Director | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 194659450001 | ||||
GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | Director | 75350600002 | |||||
JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
MALDE, Nikunj | Secretario | 32 Northiam N12 7HA London | British | 75516880001 | ||||||
MALDE, Nishith | Secretario | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | British | 148459300001 | ||||||
UPRICHARD, Andrew | Secretario | 1 Alexandra Road SK17 9NQ Buxton Derbyshire | British | 50767140001 | ||||||
ASKER, Giles Allen Trevor | Director | Nicholas Way Corringham DN21 5QE Gainsborough 9 Lincolnshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 75879360004 | ||||
BEAZER, Anthony Hadyn | Director | 172b West Hill Putney SW15 3SL London | United Kingdom | British | Director | 91412650001 | ||||
CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | Director | 154997530001 | ||||
CLARK, Ross Mckenzie | Director | 15 Hall Farm Grove Hoylandswaine S36 7LJ Barnsley South Yorkshire | British | Solicitor | 72052540003 | |||||
COLLS, Andrew John | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | Accountant | 61370150001 | ||||
DIPRE, John Vivian | Director | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 9018280015 | ||||
DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | Director | 35117250001 | ||||
FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 69006050003 | ||||
FOSTER, David Martin | Director | Bear Park 31 Nightingale Road WD3 7DA Rickmansworth Hertfordshire | England | British | Director | 50285750005 | ||||
GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | Director | 84605410002 | ||||
GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | Director | 75350600002 | ||||
HIRST, Stephen Jeremy | Director | Folds Lane S8 0ET Sheffield 157 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 95787000001 | ||||
LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Cro | 137285750001 | ||||
MALDE, Nishith | Director | Tudor House 69 Camlet Way EN4 0NL Hadley Wood Hertfordshire | England | British | Director | 148459300001 | ||||
MORTIMORE, Jon William | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Cfo | 207729000002 | ||||
WICKS, Stephen Desmond | Director | Sherwood House Oxhey Drive HA6 3EU Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Director | 42298130002 |
¿Tiene STOREY HOMES (LANCASTER)LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 09 ene 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 28 abr 2005 Entregado el 11 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 01 ago 2002 Entregado el 07 ago 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal mortgage | Creado el 23 abr 2001 Entregado el 10 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H property k/a storey home ashton road lancaster t/n LA813904. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0