LINDEN HOMES SURREY LIMITED

LINDEN HOMES SURREY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLINDEN HOMES SURREY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04138007
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LINDEN HOMES SURREY LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra LINDEN HOMES SURREY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LINDEN HOMES SURREY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PITCOMP 244 LIMITED09 ene 200109 ene 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LINDEN HOMES SURREY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LINDEN HOMES SURREY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Cowley Business Park Cowley Uxbridge Middlesex UB8 2AL el 20 sept 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Resolución de insolvencia

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 04 sept 2012

    LRESSP

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Alison Scillitoe White como secretario el 31 ene 2012

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 09 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital25 ene 2012

    Estado de capital el 25 ene 2012

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Kevin Foley como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2010

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mr Dylan May como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Colin John Rogers como director

    3 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 09 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de David Tilman como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2009

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Alison Scillitoe White como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Paul Money como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2008

    10 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de LINDEN HOMES SURREY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MAY, Dylan
    Cowley Business Park
    Cowley
    UB8 2BL Uxbridge
    Linden House
    Middlesex
    Director
    Cowley Business Park
    Cowley
    UB8 2BL Uxbridge
    Linden House
    Middlesex
    EnglandBritishLand Director140361960001
    ROGERS, Colin John
    Cowley Business Park
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Linden House
    Middlesex
    Director
    Cowley Business Park
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Linden House
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant33491280001
    AMATO, Silvano
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    Secretario
    43 Tadorne Road
    KT20 5TF Tadworth
    Surrey
    British156018520002
    MONEY, Paul David
    10 Belsize Avenue
    Ealing
    W13 9TF London
    Secretario
    10 Belsize Avenue
    Ealing
    W13 9TF London
    BritishCompany Secretary123128360001
    MORRISSEY, Brendan Jacob
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    Secretario
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    British73880040001
    STONE, Zillah Wendy
    34 Meadow Road
    SW19 2ND London
    Secretario
    34 Meadow Road
    SW19 2ND London
    British55643660001
    WHITE, Alison Scillitoe
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Cowley Business Park
    Middlesex
    Secretario
    Cowley
    UB8 2AL Uxbridge
    Cowley Business Park
    Middlesex
    146989050001
    PITSEC LIMITED
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    Secretario corporativo
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Berkshire
    38734010001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Director
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritishBanker73849040001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Director
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishBanker68241910003
    DAVIES, Philip James
    Laureldene
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    Director
    Laureldene
    Beech Avenue
    KT24 5PJ Effingham
    Surrey
    EnglandBritishChief Executive115123570001
    FOLEY, Kevin Paul
    18 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    Director
    18 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector150134410001
    JOVIC, Luba
    5 Wynlea Close
    Turner Hill Road
    RH10 4HP Crawley Down
    West Sussex
    Director
    5 Wynlea Close
    Turner Hill Road
    RH10 4HP Crawley Down
    West Sussex
    BritishFinance Director38618330002
    MORRISSEY, Brendan Jacob
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    Director
    50 Silverhill Road
    Willesborough-Lees
    TN24 0NZ Ashford
    Kent
    BritishAccountant73880040001
    PETTIFOR, Mark Andrew
    6 Woodside Close
    CR3 6AU Caterham
    Surrey
    Director
    6 Woodside Close
    CR3 6AU Caterham
    Surrey
    EnglandBritishAccountant76909360002
    TILMAN, David Ward
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Director
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director81215590001
    CASTLE NOTORNIS LIMITED
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    Director corporativo
    47 Castle Street
    RG1 7SR Reading
    39348570001

    ¿Tiene LINDEN HOMES SURREY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 dic 2004
    Entregado el 30 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transacciones
    • 30 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Confirmatory legal charge
    Creado el 22 abr 2003
    Entregado el 09 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H property on the west side of grange road guildford queen elizabeth park barracks and 8 map and chart depot guildford surrey and all guarantees waaranties easements sale proceeds insurances and other items set out in clause 2 of the charge.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Defence
    Transacciones
    • 09 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 23 mar 2001
    Entregado el 11 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or laing homes limited to the chargee under the agreement of sale excluding a). The sales overage and b). The planning overage and the additional affordable housing payments payable in respect of a planning permission granted in respect of the scheme (but including any damages payable in respect of any breach by the company of it's obligations under the agreement for sale in respect of the payments secured by the charge) or the laing's legal charge or the charge on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property on the west side of grange road guildford t/no;-SY110353 and SY691720 also k/a queen elizabeth park barracks and 8 map and chart depot excluding the retained land including any beneficial interest acquired under the collaboration agreement and the trust deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Defence
    Transacciones
    • 11 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on beneficial interests
    Creado el 23 mar 2001
    Entregado el 06 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property on the west side of grange road guildford t/n SY110353 and SY691720 also k/a queen elizabeth barracks and 8 map and charge depot and all right titles and interests in the collaberation agreement and trust dated 23 march 2001.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 23 mar 2001
    Entregado el 04 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the lenders under all or any of the finance documents or any other document evidencing or securing such liabilities (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Lenders (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 04 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene LINDEN HOMES SURREY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    21 abr 2013Fecha de disolución
    04 sept 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Steven Leslie Smith
    Mercer & Hole 72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Profesional
    Mercer & Hole 72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Peter John Godfrey-Evans
    Mercer & Hole
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts
    Profesional
    Mercer & Hole
    72 London Road
    AL1 1NS St Albans
    Herts

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0