CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04140242 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
- Educación preescolar (85100) / Educación
¿Dónde se encuentra CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Dirección de la sede social | 2 Crown Court NN10 6BS Rushden Northamptonshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GAYNES PARK NURSERY LIMITED | 12 ene 2001 | 12 ene 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2014 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mary Ann Tocio como director el 01 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 ene 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Stephen Kramer como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Stephen Dreier como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de David Lissy como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mary Ann Tocio como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Elizabeth Boland como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mary Tocio como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Lissy como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Dreier como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Boland como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Kramer como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Stephen Kramer como secretario | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Nombramiento de Elizabeth Boland como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de David Lissy como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Secretario | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | 171973360001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Director | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Director | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 170443250001 | |||||
| LISSY, Dave | Director | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 218331690001 | |||||
| BROSNAN, Paul | Secretario | Croom House IRISH Croom Co Limerick Ireland | Irish | 102089360001 | ||||||
| DHANANI, Alnur Madatali | Secretario | Simorgh Warren Road KT2 7HY Kingston Surrey | British | 2462470003 | ||||||
| HATHER, Jon | Secretario | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 68848420004 | ||||||
| HURRAN, Anthony Robert | Secretario | 10 St Marks Road Ealing W5 3JS London | British | 104970440001 | ||||||
| KRAMER, Stephen | Secretario | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | British | 169896160001 | ||||||
| MOORE, Matthew Jon | Secretario | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 134350220001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BETTUM, Ole | Director | 54 Primrose Gardens NW3 4TP London | England | Norwegian | 50551730002 | |||||
| BOLAND, Elizabeth | Director | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 70853820001 | |||||
| BROSNAN, Paul | Director | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 102089360002 | |||||
| CARNEY, Joseph Gerard | Director | 272 Gunnersbury Avenue W4 5QB London Suite 2 Chiswick Place | United Kingdom | Irish | 89273480001 | |||||
| DHANANI, Alnur Madatali | Director | Simorgh Warren Road KT2 7HY Kingston Surrey | United Kingdom | British | 2462470003 | |||||
| DREIER, Stephen | Director | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 170443250001 | |||||
| HEMSLEY, Maarten Duncan | Director | 265 Washington Street Duxbury Massachusetts 02332 Usa | United States | British | 69602210003 | |||||
| HURRAN, Anthony Robert | Director | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | England | British | 184743670001 | |||||
| LISSY, Dave | Director | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 218331690001 | |||||
| MOORE, Matthew Jon | Director | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 115340530001 | |||||
| PACE, Martin | Director | Christmas Farm Picketts Lane RH1 5RG Salfords Surrey | England | British | 74305820001 | |||||
| TERNOFSKY, Friedrich Ludwig Rudolf | Director | Kawartha Lodge Oak Grange Road West Clandon GU4 7UD Guildford Surrey | United Kingdom | Austrian | 11820520001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Director | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Director | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Tiene CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 21 dic 2004 Entregado el 06 ene 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys and liabilities due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 04 dic 2002 Entregado el 06 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Freehold property 105 gaynes park road upminster essex t/n EX21073. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 dic 2002 Entregado el 06 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 19 dic 2001 Entregado el 08 ene 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Property k/a 105 gaynes park road upminster RM14 2HX and all rights relating to the schedule property together with the contracts the book debts the intellectual property the plant and machinery the shares and derivative assets the goodwill and uncalled capital. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 30 abr 2001 Entregado el 03 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 105 gaynes park road upminster RM14 2HX.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0