CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD

CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04140242
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    • Educación preescolar (85100) / Educación

    ¿Dónde se encuentra CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Dirección de la sede social
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GAYNES PARK NURSERY LIMITED12 ene 200112 ene 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Mary Ann Tocio como director el 01 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 ene 2015

    Estado de capital el 22 ene 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 feb 2014

    Estado de capital el 06 feb 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Stephen Kramer como secretario

    1 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    11 páginasAA

    Nombramiento de Stephen Dreier como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de David Lissy como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mary Ann Tocio como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Elizabeth Boland como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mary Tocio como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Lissy como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Dreier como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Boland como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Kramer como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Stephen Kramer como secretario

    3 páginasAP03

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Nombramiento de Elizabeth Boland como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de David Lissy como director

    3 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Secretario
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    171973360001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican218331690001
    BROSNAN, Paul
    Croom House
    IRISH Croom
    Co Limerick
    Ireland
    Secretario
    Croom House
    IRISH Croom
    Co Limerick
    Ireland
    Irish102089360001
    DHANANI, Alnur Madatali
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Secretario
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    British2462470003
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Secretario
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Secretario
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    British169896160001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BETTUM, Ole
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    Director
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    EnglandNorwegian50551730002
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican70853820001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    Director
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DHANANI, Alnur Madatali
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Director
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    United KingdomBritish2462470003
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican170443250001
    HEMSLEY, Maarten Duncan
    265 Washington Street
    Duxbury
    Massachusetts 02332
    Usa
    Director
    265 Washington Street
    Duxbury
    Massachusetts 02332
    Usa
    United StatesBritish69602210003
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican218331690001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    PACE, Martin
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    Director
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    EnglandBritish74305820001
    TERNOFSKY, Friedrich Ludwig Rudolf
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    Director
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    United KingdomAustrian11820520001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    UsaUsa177507090001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Director
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    UsaUsa177507090001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene CASTERBRIDGE NURSERIES (GAYNES PARK) LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 dic 2004
    Entregado el 06 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys and liabilities due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,the Security Trustee
    Transacciones
    • 06 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 04 dic 2002
    Entregado el 06 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property 105 gaynes park road upminster essex t/n EX21073. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 dic 2002
    Entregado el 06 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 dic 2001
    Entregado el 08 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property k/a 105 gaynes park road upminster RM14 2HX and all rights relating to the schedule property together with the contracts the book debts the intellectual property the plant and machinery the shares and derivative assets the goodwill and uncalled capital. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Development Vct PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 30 abr 2001
    Entregado el 03 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    105 gaynes park road upminster RM14 2HX.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Development Vct PLC
    Transacciones
    • 03 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0