BLUHALO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBLUHALO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04140387
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BLUHALO LIMITED?

    • (7260) /

    ¿Dónde se encuentra BLUHALO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o B&C ASSOCITATES LIMITED
    Trafalgar House Grenville Place
    Mill Hill
    NW7 3SA London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BLUHALO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BLUEHALO NEW MEDIA LIMITED12 ene 200112 ene 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BLUHALO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLUHALO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    16 páginas4.72

    Domicilio social registrado cambiado de 3rd Floor the Chambers Chelsea Harbour London Greater London SW10 0XF el 15 mar 2012

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    6 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 08 mar 2012

    LRESEX

    Nombramiento de Mr Scott Cowan como director el 12 ene 2012

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 12 ene 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 abr 2011

    Estado de capital el 06 abr 2011

    • Capital: GBP 65,105
    SH01

    Cese del nombramiento de Neil Boyde como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil Boyde como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Arthur D'angelo como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Glasson como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Neil Boyde como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Janet Forgan como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Spencer Gallagher como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 ene 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Janet Roscoe el 01 oct 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Spencer Paul Gallagher el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Neil Boyde el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Spencer Paul Gallagher el 12 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Janet Roscoe el 12 ene 2010

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Richard Perry el 12 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Bluhalo Ltd el 12 ene 2010

    2 páginasCH02

    Cambio de datos del director Richard Paul Glasson el 12 ene 2010

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de BLUHALO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    D'ANGELO, Arthur
    350 5th Avenue
    Suite 2800
    NY10118 New York
    The Empire State Building
    New York
    Usa
    Secretario
    350 5th Avenue
    Suite 2800
    NY10118 New York
    The Empire State Building
    New York
    Usa
    159138760001
    COWAN, Scott
    c/o B&C Associtates Limited
    Grenville Place
    Mill Hill
    NW7 3SA London
    Trafalgar House
    Director
    c/o B&C Associtates Limited
    Grenville Place
    Mill Hill
    NW7 3SA London
    Trafalgar House
    EnglandBritishLogistics Director165862900001
    PERRY, Richard
    c/o B&C Associtates Limited
    Grenville Place
    Mill Hill
    NW7 3SA London
    Trafalgar House
    Director
    c/o B&C Associtates Limited
    Grenville Place
    Mill Hill
    NW7 3SA London
    Trafalgar House
    United KingdomBritishManager103104420006
    BOYDE, Neil
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    3rd Floor The Chambers
    Greater London
    Secretario
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    3rd Floor The Chambers
    Greater London
    153573840001
    FORGAN, Janet
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    3rd Floor The Chambers
    Greater London
    Secretario
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    3rd Floor The Chambers
    Greater London
    BritishCompany Director119207370004
    HOOLE, Peter Adrian
    22 Barentin Way
    Ramshill
    GU31 4QN Petersfield
    Hampshire
    Secretario
    22 Barentin Way
    Ramshill
    GU31 4QN Petersfield
    Hampshire
    British87216930002
    BATLON SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    44 Essex Street
    Strand
    WC2R 3JF London
    Secretario corporativo
    44 Essex Street
    Strand
    WC2R 3JF London
    82590840001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ASHLEY, Philip Harry
    Scamperdale Cottage
    Main Road
    TN8 6SN Crockham Hill
    Kent
    Director
    Scamperdale Cottage
    Main Road
    TN8 6SN Crockham Hill
    Kent
    EnglandBritishConsultant78876300001
    BOYDE, Neil
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    3rd Floor The Chambers
    Greater London
    Director
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    3rd Floor The Chambers
    Greater London
    United KingdomBritishCfo138054240002
    BRINE, Gary Edward
    2 Springwood Place
    Cobbetts Hill
    KT13 0UB Weybridge
    Surrey
    Director
    2 Springwood Place
    Cobbetts Hill
    KT13 0UB Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director34997210018
    GALLAGHER, Spencer Paul
    c/o Bluhalo Ltd
    Fowler Avenue
    GU14 7JP Farnborough
    The Hub
    Hampshire
    United Kingdom
    Director
    c/o Bluhalo Ltd
    Fowler Avenue
    GU14 7JP Farnborough
    The Hub
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director94034390001
    GLASSON, Richard Paul
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    3rd Floor The Chambers
    Greater London
    Director
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    3rd Floor The Chambers
    Greater London
    EnglandBritishCompany Director84491310003
    HENDERSON, Ronald
    Tudor Court
    171 Upper Chobham Road
    GU15 1EH Camberley
    Surrey
    Director
    Tudor Court
    171 Upper Chobham Road
    GU15 1EH Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishCo Director2123590004
    BLUHALO LTD
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Third Floor
    Director corporativo
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Third Floor
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroN/A
    146432930001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Tiene BLUHALO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 04 abr 2008
    Entregado el 09 abr 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 25 jul 2007
    Entregado el 31 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 jul 2007
    Entregado el 27 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Venture Finance PLC
    Transacciones
    • 27 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 13 jul 2007
    Entregado el 20 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Liabilities under a lease of premises k/a suites 8 and 9 the hub farnborough business park farnborough hampshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Farnborough Business Park Limited
    Transacciones
    • 20 jul 2007Registro de un cargo (395)
    Rental deposit deed
    Creado el 20 dic 2004
    Entregado el 23 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A deposit of £2,423.48 together with interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew William Goddard
    Transacciones
    • 23 dic 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 02 dic 2004
    Entregado el 07 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 jul 2004
    Entregado el 08 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creado el 24 sept 2003
    Entregado el 02 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Deposit of £3,231.25 together with accrued interest and additions thereto pursuant to the terms of the rental deposit deed dated 24 september 2003 and made between andrew william goddard (1) bluehalo mdie limited (2).
    Personas con derecho
    • Andrew William Goddard
    Transacciones
    • 02 oct 2003Registro de un cargo (395)
    Rental deposit deed
    Creado el 01 feb 2002
    Entregado el 06 feb 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The deposit of £3,231.25 together with accrued interest.
    Personas con derecho
    • Andrew William Goddard
    Transacciones
    • 06 feb 2002Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene BLUHALO LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 mar 2012Inicio de la liquidación
    22 ago 2013Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jeffrey Mark Brenner
    B & C Associates Limited Trafalgar House
    Grenville Place Mill Hill
    NW7 3SA London
    Profesional
    B & C Associates Limited Trafalgar House
    Grenville Place Mill Hill
    NW7 3SA London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0