LAKESIDE CENTRE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LAKESIDE CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04144192 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LAKESIDE CENTRE LIMITED?
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra LAKESIDE CENTRE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5 Churchill Place 10th Floor E14 5HU London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LAKESIDE CENTRE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INTU LAKESIDE LIMITED | 15 feb 2013 | 15 feb 2013 |
| CSC LAKESIDE LIMITED | 14 feb 2001 | 14 feb 2001 |
| HACKREMCO (NO.1778) LIMITED | 19 ene 2001 | 19 ene 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LAKESIDE CENTRE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para LAKESIDE CENTRE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 ene 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 13 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 ene 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LAKESIDE CENTRE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 30 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 28 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Wodehouse Williams como director el 16 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Bryan Harris como director el 16 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Matthew Lurie como director el 08 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Jacob Lunsingh Tonckens como director el 08 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrea Trozzi como director el 08 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Jonathan Robson como director el 08 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jeremy Michael Jorgen Malherbe Jensen como director el 08 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 041441920006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 041441920007 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Registro de la carga 041441920008, creada el 17 abr 2024 | 46 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 9 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des détails de Sgs 2020 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 feb 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 30 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 28 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 28 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LAKESIDE CENTRE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England |
| 239196070001 | ||||||||||
| HARRIS, Christopher Bryan | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | England | British | 312670880001 | |||||||||
| LURIE, Jonathan Matthew | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | England | British | 322864430001 | |||||||||
| TONCKENS, Jacob Lunsingh | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | United States | American | 322865280001 | |||||||||
| WILLIAMS, Peter Wodehouse | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | England | British | 135547730001 | |||||||||
| MARSDEN, Susan | Secretario | Broadway SW1H 0BT London 40 England And Wales United Kingdom | British | 68599110004 | ||||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
| INTU SECRETARIAT LIMITED | Secretario corporativo | Broadway SW1H 0BT London 40 United Kingdom |
| 261859510001 | ||||||||||
| ABEL, John George | Director | 9 Hutton Gate Hutton Mount CM13 2XA Brentwood Essex | Uk | British | 14465220002 | |||||||||
| AINSLEY, Jonathan Mark | Director | 4 Locke Road GU30 7DQ Liphook Hampshire | United Kingdom | British | 119641880001 | |||||||||
| ALLEN, Robert Lee | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | United Kingdom | British | 132793870003 | |||||||||
| BADCOCK, Peter Colin | Director | Wilsley Oast Wilsley Green, Angley Road TN17 2LE Cranbrook Kent | England | British | 545530002 | |||||||||
| BARTON, Peter Charles | Director | Warren House Shire Lane WD3 5NH Chorleywood Hertfordshire | England | British | 165160480001 | |||||||||
| BOWYER, Katharine Ann | Director | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | 190760710001 | |||||||||
| BREEDEN, Martin Richard | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | United Kingdom | British | 250543330001 | |||||||||
| BREEDEN, Martin Richard | Director | 21 Bramley Road SM2 7LR Cheam Surrey | United Kingdom | British | 250543330001 | |||||||||
| CABLE, Richard Malcolm | Director | 47 Peterborough Road Castor PE5 7AX Peterborough The Old Smithy United Kingdom | England | British | 65264230002 | |||||||||
| CHALDECOTT, Kay Elizabeth | Director | 40 Broadway London SW1H 0BU | England | British | 68694110002 | |||||||||
| CROSBY, Sean | Director | Broadway SW1H 0BT London 40 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 261481480001 | |||||||||
| ELLIS, Martin David | Director | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | 108375330002 | |||||||||
| ELLIS, Martin David | Director | Netherby Lower Pond Street Duddenhoe End CB11 4UP Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 108375330002 | |||||||||
| FISCHEL, David Andrew | Director | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | 8845220002 | |||||||||
| FLINN, Colin | Director | 40 Broadway SW1H 0BT London Intu Properties Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 205809260001 | |||||||||
| FORD, Hugh Michael | Director | Broadway SW1H 0BT London 40 England And Wales United Kingdom | England | British | 165108940002 | |||||||||
| GIBBES, Barbara | Director | Broadway SW1H 0BT London 40 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 204716830001 | |||||||||
| GRANT, Kathryn Anne | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | United Kingdom | British | 250502670001 | |||||||||
| GRANT, Kathryn Anne | Director | The White Lodge 16 Fir Grange Avenue KT13 9AR Weybridge Surrey | England | British | 119649490001 | |||||||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | England | British | 108268030003 | |||||||||
| KIDIA, Minakshi | Director | Broadway SW1H 0BT London 40 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 261482420001 | |||||||||
| KIRBY, Caroline | Director | 40 Broadway London SW1H 0BU | England | British | 108375400001 | |||||||||
| LESLIE, Douglas Ross | Director | 8 Faircourt 113-115 Haverstock Hill NW3 4RY London | British | 40685970002 | ||||||||||
| PEREIRA, Trevor | Director | Broadway SW1H 0BT London 40 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 125130130001 | |||||||||
| PEREIRA, Trevor | Director | 42 Castle Road GU15 2DS Camberley Surrey | United Kingdom | British | 125130130001 | |||||||||
| ROBERTS, Edward Matthew Giles, Dr | Director | Broadway SW1H 0BT London 40 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 154029500001 | |||||||||
| ROBSON, Neil Jonathan | Director | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | United Kingdom | British | 92733530003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LAKESIDE CENTRE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgs 2020 Limited | 06 abr 2016 | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0