ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04146543 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Sands Mill Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ELANTRIAL LIMITED | 24 ene 2001 | 24 ene 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 p áginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 sept 2018
| 8 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 sept 2018
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 28 sept 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Gregory Francis Kilmister como director el 20 jul 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr John Raymond Crabtree como secretario el 20 jul 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Edward Mullen como secretario el 20 jul 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 19 páginas | AA | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ene 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ene 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 24 ene 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Wood como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Masters como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Wood como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Mark Andrew Kenneth Wood el 03 oct 2013 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRABTREE, John Raymond | Secretario | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | 236088830001 | |||||||
| MASTERS, Matthew Graham | Director | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | England | British | 183080130001 | |||||
| CLUBB, Adrian | Secretario | Roman Way Borrowash DE72 3LX Derby 18 Derbyshire | British | 130740700001 | ||||||
| EVAN-COOK, Paul | Secretario | Borderigg Benhall Mill Road TN2 5JH Tunbridge Wells Kent | British | 7658310001 | ||||||
| LEIGH, Richard Ian | Secretario | 170 Haverstock Hill NW3 2AT London | British | 47707160001 | ||||||
| MULLEN, Timothy Edward | Secretario | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | British | 168488100001 | ||||||
| SOWERBY, Richard Anthony | Secretario | 49a Carr Hill Road Upper Cumberworth HD8 8XN Huddersfield | British | 60728080002 | ||||||
| WOOD, Mark Andrew Kenneth | Secretario | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | British | 113494040001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| ATWOOD, Robert Charles | Director | Breakstones Speldhurst Road Langton Green TN3 0JL Tunbridge Wells Kent | England | British | 14065630001 | |||||
| DEDMAN, Julie Elizabeth | Director | Hopton Brow 102 Hopton Lane WF14 8JP Upper Hopton Mirfield | England | British | 141993660001 | |||||
| FLYNN, Theresa May | Director | 44 Thornton Way Girton CB3 0NJ Cambridge | British | 29751450003 | ||||||
| GOMAR, Mark James | Director | Grubbs Lane Hatfield AL9 6EF Hertfordshire Westfield House | United Kingdom | British | 133321960001 | |||||
| KILMISTER, Gregory Francis | Director | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | Australia | Australian | 161659660001 | |||||
| LOUDEN, Nicholas William | Director | Ashby Road DE15 0YZ Bretby Esg House Bretby Business Park Burton On Trent | Wales | British | 76293900002 | |||||
| MCBRIDE, Richard Anthony | Director | 10 Buckingham Street WC2N 6DF London | Uk | British | 80081060003 | |||||
| MCDOUGALL, Neil | Director | Strood Place Strood Lane RH12 3PF Warnham West Sussex | British | 74825350001 | ||||||
| SILVER, Mark Jonathan | Director | 10 Buckingham Street WC2N 6DF London | British | British | 42369970005 | |||||
| SLEETH, Alexander, Mr | Director | Brackenwood Mews Wynchwood Mews CW2 5GQ Weston 6 Cheshire | United Kingdom | Scottish | 154283090002 | |||||
| SOWERBY, Richard Anthony | Director | 49a Carr Hill Road Upper Cumberworth HD8 8XN Huddersfield | England | British | 60728080002 | |||||
| TOZZI, Keith | Director | 20 Black Friars Lane EC4V 6HD London | United Kingdom | British | 58029330001 | |||||
| TOZZI, Keith | Director | 20 Black Friars Lane EC4V 6HD London | United Kingdom | British | 58029330001 | |||||
| WOOD, Mark Andrew Kenneth | Director | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill West Yorkshire | England | British | 113494040001 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Director designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eclipse Acquisitions Limited | 06 abr 2016 | Huddersfield Road WF14 9DQ Mirfield Sands Mill England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ECLIPSE SCIENTIFIC HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Creado el 08 sept 2010 Entregado el 16 sept 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any member of the group and by each debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating security document | Creado el 14 may 2008 Entregado el 23 may 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All its present and future right title and interest in and to the assigned agreements, see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of accession to a debenture originally dated 6 october 2005 as amended and restated on 28 april 2006 | Creado el 11 ago 2006 Entregado el 19 ago 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any group company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0