CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04152031 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Dirección de la sede social | One Park Lane LS3 1EP Leeds |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| COACTIVA ASPIREN LTD | 25 oct 2010 | 25 oct 2010 |
| SUNGARD PUBLIC SECTOR ASPIREN LIMITED | 02 ene 2008 | 02 ene 2008 |
| SUNGARD ASPIREN LIMITED | 03 sept 2007 | 03 sept 2007 |
| ASPIREN LIMITED | 27 may 2003 | 27 may 2003 |
| PERFORM FIRST LTD | 31 jul 2001 | 31 jul 2001 |
| THE PERFORMANCE PARTNERSHIP.COM LIMITED | 01 feb 2001 | 01 feb 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 25 páginas | AA | ||||||||||||||
Cessation de Coactiva Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 may 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Notification de Transunion International Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 may 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr William John Flynn como director el 11 may 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 15 may 2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Satrijit Saha el 01 mar 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Satrijit Saha como director el 25 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Colin James Rutter como director el 29 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Colin James Rutter como secretario el 29 feb 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 26 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Kenneth Campbell Munro como director el 01 abr 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Jon Gordon como director el 08 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Edward Horsey como director el 13 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Colin James Rutter como director el 13 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Colin James Rutter como secretario el 13 feb 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Kenneth Campbell Munro como secretario el 13 feb 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLYNN, William John | Director | Park Lane LS3 1EP Leeds One | United Kingdom | British | 269944900001 | |||||
| HORSEY, Mark Edward | Director | Park Lane LS3 1EP Leeds One | United Kingdom | British | 196671230001 | |||||
| SAHA, Satrajit | Director | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | Indian | 267916570002 | |||||
| KNIGHTON, Christopher | Secretario | 11 Ackmar Road Fulham SW6 4UP London | British | 74366030002 | ||||||
| KNIGHTON, Esther | Secretario | 14 Beechwood Road DD11 4HS Arbroath Angus | British | 74365870001 | ||||||
| MUNRO, Robert Kenneth Campbell | Secretario | Park Lane LS3 1EP Leeds One | 197751810001 | |||||||
| RICHARDS, Elizabeth Anne | Secretario | Park Lane LS3 1EP Leeds One | British | 185280220001 | ||||||
| RUTTER, Colin James | Secretario | Park Lane LS3 1EP Leeds One | 255307610001 | |||||||
| WALLIS, Howard | Secretario | Brindle Lodge New Road, Headcorn TN27 9SE Ashford Kent | British | 80930830001 | ||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Secretario designado corporativo | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
| ASHWORTH, Gary | Director | 3 Chapel Heights Bolnore Road RH16 4AN Haywards Heath West Sussex | British | 101851590001 | ||||||
| BRAIN, Bruce | Director | West Sevington Farmhouse Yatton Keynell SN15 4NB Chippenham Wiltshire | United Kingdom | British | 9395440004 | |||||
| BURGE, Alan | Director | Home Farm Close BA14 6AH Steeple Ashton 5 Wiltshire | United Kingdom | British | 197259620001 | |||||
| CHAPMAN, Brian Roy | Director | Spring Acre Lower Washwell Lane GL6 6XW Painswick Gloucestershire | United Kingdom | British | 32009220003 | |||||
| FIELDING, Raymond Albert George | Director | Lombard Street EC3V 9LJ London 68 | United Kingdom | British | 154664990001 | |||||
| GIBSON, John Leonard | Director | Poffley End Hailey OX29 9UW Nr Witney Winnings Farmhouse Oxfordshire | United Kingdom | British | 173207750001 | |||||
| GORDON, Michael Jon | Director | Park Lane LS3 1EP Leeds One | United Kingdom | British | 194337270002 | |||||
| KING, Evan Wayne | Director | 24 Isaacson Road CB5 0AF Burwell Cambridgeshire | British | 106540190001 | ||||||
| KNIGHTON, Christopher | Director | 11 Ackmar Road Fulham SW6 4UP London | England | British | 74366030002 | |||||
| MCANDREW, John Francis | Director | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | British | 102419830002 | |||||
| MUNRO, Robert Kenneth Campbell | Director | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | British | 137091090001 | |||||
| RICHARDS, Elizabeth Anne | Director | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | British | 61958280002 | |||||
| RICHARDS, Elizabeth Anne | Director | Cavendish Avenue HG2 8HY Harrogate 23 North Yorkshire England | England | British | 61958280002 | |||||
| RUANE, Michael Joseph | Director | 11 Wembley Drive 08054 Mount Laurel New Jersey Usa | Usa | United States | 46331880001 | |||||
| RUTTER, Colin James | Director | Park Lane LS3 1EP Leeds One | England | British | 123440320001 | |||||
| SANTOS, Gilbert Omar, Mr. | Director | 7731 Flemingwood Ct. Sanford Florida 32771 Usa | Usa | American | 122432060001 | |||||
| SILBEY, Victoria Elizabeth | Director | 15 Fox Ridge Drive 19355 Malvern Pennsylvania Usa | United States Of America | American | 110055430002 | |||||
| WATSON, Nigel | Director | 13 Gordon Road E11 2RA London | England | British | 87589920001 | |||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Director designado corporativo | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transunion International Uk Limited | 29 may 2020 | Park Lane LS3 1EP Leeds 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Coactiva Limited | 06 abr 2016 | Park Lane LS3 1EP Leeds One England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CALLCREDIT PUBLIC SECTOR LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 09 abr 2014 Entregado el 16 abr 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 19 dic 2012 Entregado el 07 ene 2013 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The sum of £20,000. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 may 2005 Entregado el 26 may 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0