SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04157380 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
- Actividades hospitalarias (86101) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 Park Row LS1 5AB Leeds United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 23 feb 2026 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 09 mar 2026 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 23 feb 2025 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 23 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Thomas Solley como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Cameron Hannah Mclure como director el 31 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 32 páginas | AA | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 dic 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Dalmore Capital Limited Watling House, 5th Floor 33 Cannon Street London EC4M 5SB United Kingdom a 1 Park Row Leeds LS1 5AB el 05 jun 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 feb 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Dalmore Capital Limited 33 Cannon Street London EC4M 5SB United Kingdom a C/O Dalmore Capital Limited Watling House, 5th Floor 33 Cannon Street London EC4M 5SB el 12 dic 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Albany Spc Services Limited 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street Manchester M1 4HB England a C/O Dalmore Capital Limited 33 Cannon Street London EC4M 5SB el 08 dic 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Ailison Louise Mitchell como secretario el 30 nov 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Resolis Limited como secretario el 01 dic 2022 | 2 páginas | AP04 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 30 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Roger Mark Thompson como director el 01 abr 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Ms Ailison Louise Mitchell como secretario el 31 ene 2022 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Wendy Lisa Rapley como secretario el 31 ene 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 29 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr. Matthew Templeton como director el 01 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de John Stephen Gordon como director el 01 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 29 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 feb 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 29 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESOLIS LIMITED | Secretario corporativo | 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh Exchange Tower, 11th Floor United Kingdom |
| 285489620001 | ||||||||||
MCLURE, Cameron Hannah | Director | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 Scotland Scotland | Scotland | British | Associate Director | 331818510001 | ||||||||
SMITH, Martin Timothy | Director | KY11 1ER North Queensferry 9 Carlingnose Point Fife Scotland | Scotland | British | Banker | 82478070001 | ||||||||
TEMPLETON, Matthew | Director | 19a, Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital Ltd, Caledonian Exchange Scotland | Scotland | British | Director | 175541650001 | ||||||||
LEWIS, Martin | Secretario | Apartment 503 87 Branston Street B18 6BT Birmingham | British | 79300270005 | ||||||||||
MCEVEDY, David Jason | Secretario | The Old Chapel Parsons Lane Hartgrove SP7 0LF Shaftesbury Dorset | British | Accountant | 69462470002 | |||||||||
MITCHELL, Ailison Louise | Secretario | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Limited England | 292082200001 | |||||||||||
RAPLEY, Wendy Lisa, Mrs. | Secretario | Office 201, 400 Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading Albany Spc Services Limited Berkshire United Kingdom | British | 74196190008 | ||||||||||
SANDERS, Jan | Secretario | Danes Cottage Navestock Side CM14 5SE Brentwood Essex | British | Solicitor | 98651250001 | |||||||||
SMERDON, Leigh | Secretario | 1 Cedar Grove The Hedgerows Great Wyrley WS6 6QH Walsall West Midlands | Other | 89075910001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
AULD, Charles Cairns | Director | 2 Cheyne Row SW3 5HL London | United Kingdom | British | Consultant | 23257420003 | ||||||||
BALFOUR, Ion Bruce | Director | Bow Bells House 1 Bread Street EC4M 9HH London Aberdeen Asset Management Plc London England | United Kingdom | British | Investment Director | 192983050001 | ||||||||
BREMNER, Alexander George | Director | South Street KY16 9QU St. Andrews 24 Fife Scotland | Scotland | British | Pfi/Ppp Management Consultant | 152806580003 | ||||||||
CLAMPETT, Richard Martin | Director | Stonerest Stone Lane, Emley HD8 9RT Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 91834040001 | ||||||||
DARLING, Andrew David | Director | 4 Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow West Lothian | British | Banker | 73218540001 | |||||||||
DARROCH, Michael Geoffrey | Director | 22 Rheidol Terrace N1 8NS London | British | Director | 50793940001 | |||||||||
DICKINSON, Victoria Helen | Director | Flat 5 243a Wimbledon Park Road SW18 5RJ London | British | Bank Employee | 80242100001 | |||||||||
DONN, Michael Andrew | Director | Lloyds Banking Group 2nd Floor, New Uberior House, 11 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh Lloyds Banking Group Scotland | Scotland | British | Banker | 108352120001 | ||||||||
ELEY, Ralph Bruce | Director | 23 Ailsa Avenue St Margarets TW1 1NF Twickenham | British | Banker | 74957450001 | |||||||||
GORDON, John Stephen | Director | 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Dalmore Capital, Caledonian Exchange Scotland | Scotland | British | Director | 203724200001 | ||||||||
GRANT, Philip Robert | Director | 40 Lumsdaine Drive KY11 9YU Dalgety Bay Fife | British | Banker | 76673520001 | |||||||||
HARRIS, John David | Director | Floor 200 Aldersgate Street, EC1A 2ND London 17th | England | British | Fund Manager | 174333200001 | ||||||||
JONES, Stephen Michael | Director | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Limited England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 88268290002 | ||||||||
MARSDEN, Robert James | Director | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Limited England | England | British | Project Manager | 86971250002 | ||||||||
MCDONAGH, John | Director | Floor 200 Aldersgate Street, EC1A 2ND London 17th | England | British | Director | 192240500001 | ||||||||
MELIZAN, Bruce Anthony | Director | Willowmead Orchard Road RG10 0SD Hurst Berkshire | United Kingdom | British,Trinidadian | Managing Director | 92905500001 | ||||||||
ORAM, Robin James | Director | Eaton Court Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Sir Robert Mcalpine Hertfordshire England | United Kingdom | British | General Manager | 105719990001 | ||||||||
ORAM, Robin James | Director | The Mill House Aynsome Mill Farm LA11 6HH Grange Over Sands Cumbria | United Kingdom | British | General Manager | 105719990001 | ||||||||
PATEL, Rajeshree | Director | Flat 19 45 Barkston Gardens SW5 0ES London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 100502650001 | ||||||||
POYNTON, David, Mr. | Director | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | United Kingdom | British | Chairman | 9831070008 | ||||||||
RICHARDS, Ceri | Director | Hardown House Park View Road, Woldingham CR3 7DH Surrey | British | Banker | 70624480002 | |||||||||
RINGROSE, Adrian Michael | Director | 66 Bedford Avenue EN5 2ER Barnet Hertfordshire | British | Director | 74958050001 | |||||||||
SHELLEY, Miles Colin | Director | Sir Robert Mcalpine Eaton Court, Maylands Avenue HP2 7TR Hemel Hempstead Sir Robert Mcalpine Hertfordshire England | England | British | Chartered Accountant | 44005940002 | ||||||||
SOLLEY, Christopher Thomas | Director | 40 Princes Street EH2 2BY Edinburgh Aberdeen Asset Management Plc Scotland | United Kingdom | British | Banker | 166666620001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited | 06 abr 2016 | Bishopsgate EC2M 4AG London 280 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Crimson Project Investments Limited | 06 abr 2016 | LS1 5AB Leeds 1 Park Row England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Browning Pfi Holdings Limited | 06 abr 2016 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SUMMIT HOLDINGS (DUDLEY) LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
15 feb 2017 | 06 abr 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0