REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED

REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaREMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED
    Estado de la empresaBajo administración judicial
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04171982
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED?

    • (7011) /

    ¿Dónde se encuentra REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INHOCO 2268 LIMITED02 mar 200102 mar 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el28 feb 2011
    Próximas cuentas vencen el30 nov 2011
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2010

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta02 mar 2017
    Próxima declaración de confirmación vence16 mar 2017
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    legacy

    3 páginasLQ01

    legacy

    2 páginasLQ02

    Cese del nombramiento de Valad Secretarial Services Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Valsec Director Limited como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christian Bearman como director

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasLQ01

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 mar 2011

    Estado de capital el 04 mar 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del secretario Valad Secretarial Services Limited el 09 dic 2010

    3 páginasCH04

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 28 feb 2010

    7 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Valad Secretarial Services Limited el 16 sept 2010

    3 páginasCH04

    Déclaration annuelle établie au 02 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Valsec Director Limited el 02 mar 2010

    2 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Valad Secretarial Services Limited el 02 mar 2010

    2 páginasCH04

    Nombramiento de Mr Christian James Alexander Bearman como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Maddy como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de James Edward Maddy como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Didier Tandy como director

    2 páginasTM01

    Cambio de datos del director Didier Michel Tandy el 22 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Didier Michel Tandy el 07 oct 2009

    3 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2009

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    9 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    6 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Secretario
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Secretario
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    NAIK, Varsha
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    Secretario
    14 Brearley Close
    Pavilion Way
    HA8 9YT Edgware
    Middlesex
    British101693390001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario designado corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC219311
    133355520001
    BEARMAN, Christian James Alexander
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Director
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish110436370002
    CORLETT, Robert John
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    102 Deacon Road
    KT2 6LU Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish72399980002
    GILMAN, Peter John
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    The Sashes
    Holgate Lane Boston Spa
    LS23 6BN Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish35528040001
    LIGHTBODY, Bruce Robson
    148 Almsford Drive
    HG2 8EE Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    148 Almsford Drive
    HG2 8EE Harrogate
    North Yorkshire
    British75214270001
    MADDY, James Edward
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Director
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United KingdomBritish137459000001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Director
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OLIVER, Paul Francis
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    Director
    Curlew House 58 Grove Park Gardens
    Chiswick
    W4 3RZ London
    United KingdomBritish14735150002
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Director
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Director
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish69909950001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Director
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TUTTON, Jeremy John
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    Director
    31 Chester Way
    Kennington
    SE11 4UR London
    British100816670001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Director designado corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Director corporativo
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5307786
    102622300002

    ¿Tiene REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite debenture and guarantee
    Creado el 28 jun 2006
    Entregado el 12 jul 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company the chargors and each of them to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The l/h property at plot 1175 thorpe park leeds t/n WYK734083, part of plot 1250 thorpe park leeds t/n WYK691297, plot 2100 thorpe park leeds t/n WYK691298, for details of further properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capmark Bank Europe PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 12 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 127 may 2011Nombramiento de un receptor o gerente (LQ01)
    • 115 mar 2013Aviso de cese de funciones como receptor o gerente (LQ02)
    • 115 mar 2013Nombramiento de un receptor o gerente (LQ01)
      • Número de expediente 1
    Debenture
    Creado el 10 abr 2003
    Entregado el 11 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 abr 2003Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 07 mar 2003
    Entregado el 17 mar 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 mar 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 31 mar 2001
    Entregado el 10 abr 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 1250 (b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plot 1250 thorpe park leeds. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 abr 2001Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 31 mar 2001
    Entregado el 10 abr 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as remote properties 1250 (b) limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 abr 2001Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene REMOTE PROPERTIES 1250 (B) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1Administrador judicial/gestor nombrado
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Hugh Lawrence Dorins
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Administrador judicial/gestor
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Robert Stokely
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Administrador judicial/gestor
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Colin Richard Jennings
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London
    Administrador judicial/gestor
    2 Southwark Street
    London Bridge
    SE1 1TQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0