BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED

BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04175866
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    • Servicios de representación de medios (73120) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PROMOTION SPACE LIMITED24 mar 200324 mar 2003
    CPL HOLDINGS LIMITED29 ago 200129 ago 2001
    PARTNERSHIPS@ LIMITED08 mar 200108 mar 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    18 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2018

    16 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2017

    12 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2016

    12 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 mar 2015

    11 páginas4.68

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:block transfer order - replacement of liquidator
    47 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Informe de progreso del administrador hasta 28 mar 2014

    16 páginas2.24B

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 04 oct 2013

    13 páginas2.24B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    8 páginas2.16B

    Declaración de la propuesta del administrador

    35 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de * 2Nd Floor Egginton House 25-28 Buckingham Gate London SW1E 6LD England* el 18 abr 2013

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Domicilio social registrado cambiado de * 7Th Floor South Artillery House 11-19 Artillery Row London London SW1P 1RT England* el 27 mar 2013

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Ms Michelle De Young como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul Soanes como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sean Fay como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * Sandfield House Water Lane Wilmslow Cheshire SK9 5AR* el 13 sept 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 08 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 mar 2012

    Estado de capital el 22 mar 2012

    • Capital: GBP 1,188.61
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Director
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandBritish140102770001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Secretario
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    British22089740001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Secretario
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    OCS CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    Secretario corporativo
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    71518050017
    COCKSHUTT, Diane
    2 Place Road
    WA14 4HH Altrincham
    Cheshire
    Director
    2 Place Road
    WA14 4HH Altrincham
    Cheshire
    British75151590001
    FAY, Sean Ernan
    Floor South Artillery House
    11-19 Artillery Row London
    SW1P 1RT London
    7th
    England
    Director
    Floor South Artillery House
    11-19 Artillery Row London
    SW1P 1RT London
    7th
    England
    United KingdomIrish84925400001
    FUSCO, Robert
    3 Blenheim Close
    SK9 2DN Wilmslow
    Cheshire
    Director
    3 Blenheim Close
    SK9 2DN Wilmslow
    Cheshire
    British105982320001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Director
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    UkBritish22089740001
    HIGHAM, Robin Jeremy Charles
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    Director
    46 Fernwood
    Marple Bridge
    SK6 5BE Stockport
    Cheshire
    UkBritish22089740001
    HOWARD, Peter
    Lower Stone Ridge
    Green Lane, Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    Director
    Lower Stone Ridge
    Green Lane, Disley
    SK12 2AL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish77112140001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Director
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Director
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish102300760001
    SOANES, Paul Henry
    Sparrow Row
    Chobham
    GU24 8TA Woking
    Woodside
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Sparrow Row
    Chobham
    GU24 8TA Woking
    Woodside
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish68377030007
    SOAR, Guy Jason
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    Director
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    United KingdomBritish96671300002
    SOAR, Guy Jason
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    Director
    40 Brookfield Avenue
    Timperley
    WA15 6TH Altrincham
    Cheshire
    British96671300001
    OCS DIRECTORS LIMITED
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    Director designado corporativo
    Minshull House
    67 Wellington Road North
    SK4 2LP Stockport
    Cheshire
    900021490001

    ¿Tiene BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 jun 2010
    Entregado el 08 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to beocme due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transacciones
    • 08 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 02 nov 2009
    Entregado el 13 nov 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 nov 2009Registro de un cargo (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Creado el 14 jul 2009
    Entregado el 31 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Investments Limited
    Transacciones
    • 31 jul 2009Registro de un cargo (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    Guarantee & debenture
    Creado el 30 abr 2008
    Entregado el 07 may 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transacciones
    • 07 may 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 28 nov 2007
    Entregado el 11 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 11 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 30 abr 2007
    Entregado el 11 may 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 11 may 2007Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene BRANDSPACE (WILMSLOW) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 abr 2013Inicio de la administración
    28 mar 2014Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    FechaTipo
    28 mar 2014Inicio de la liquidación
    16 ene 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Liquidador propuesto
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Liquidador propuesto
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Neville Side
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Profesional
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0