COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04176659 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Dirección de la sede social | 15 Shenley Pavilions Shenley Wood MK5 6LB Milton Keynes Buckinghamshire England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 jun 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 22 jun 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 jun 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2023 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2022 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Ilux, 3 Cabot House Compass Point Business Park Stocks Bridge Way St. Ives Cambridgeshire PE27 5JL England a 15 Shenley Pavilions Shenley Wood Milton Keynes Buckinghamshire MK5 6LB el 13 jun 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2021 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Segunda presentación de la Declaración de confirmación fechada el 08 jun 2022 | 4 páginas | RP04CS01 | ||||||||||
08/06/22 Statement of Capital gbp 769.15 | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 30 jul 2021
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 ago 2021 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ocean House the Ring Bracknell Berkshire RG12 1AN United Kingdom a C/O Ilux, 3 Cabot House Compass Point Business Park Stocks Bridge Way St. Ives Cambridgeshire PE27 5JL el 16 ago 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 2 páginas | SH10 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Patrick Penton Tilbury como director el 30 jul 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cessation de Rebecca Louise Hazel Taylor en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jul 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Clive John Ansell como director el 30 jul 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cessation de Kevin Paul Sey en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 jul 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Paul Sey como director el 30 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rebecca Louise Hazel Taylor como director el 30 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notification de Rebecca Louise Hazel Taylor en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jun 2021 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Cessation de Thorsten Kühl en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 jul 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thorsten Kühl como director el 15 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Rebecca Louise Hazel Taylor como director el 01 jun 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSELL, Clive John | Director | Compass Point Business Park Stocks Bridge Way PE27 5JL St Ives Unity House Cambridgeshire England | United Kingdom | British | Managing Director | 49279910003 | ||||||||
TILBURY, James Patrick Penton | Director | Compass Point Business Park Stocks Bridge Way PE27 5JL St. Ives 3 Cabot House Cambridgeshire England | England | British | Ceo | 124909610002 | ||||||||
BULLOCK, Peter Kenneth | Secretario | 4 Wigley Road Scraptoft Lane LE5 1JG Leicester Leicestershire | British | 79166480001 | ||||||||||
HOMA, Peter Andrew | Secretario | 3 Totale Rise Warfield RG42 2PW Bracknell Berkshire | British | Chartered Accountant | 82230400001 | |||||||||
LI, Jane | Secretario | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Company Secretary Berkshire England | 202894450001 | |||||||||||
NEWSHOLME, Richard John | Secretario | Gatesgarth Airton BD23 4AL Skipton North Yorkshire | British | Property Manager | 22195530004 | |||||||||
ROWLAND, Julie Claire | Secretario | The Paddocks 11 Warkton Lane NN15 5AB Kettering Northamptonshire | British | 82947230001 | ||||||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire England |
| 182070760001 | ||||||||||
BOULD, Daniel Robert | Director | The Barn Chadstone Castle Ashby NN7 1LH Northampton | British | Company Director | 43899880001 | |||||||||
BOULD, Nicholas Daniel | Director | Stone Cottage Well Lane, PE8 5PF Barnwell Northamptonshire | United Kingdom | British | Dvelopment Surveyor | 84481140001 | ||||||||
BULLOCK, Peter Kenneth | Director | 4 Wigley Road Scraptoft Lane LE5 1JG Leicester Leicestershire | British | Chartered Accountant | 79166480001 | |||||||||
BULLOCK, Peter Kenneth | Director | 4 Wigley Road Scraptoft Lane LE5 1JG Leicester Leicestershire | British | Chartered Accountant | 79166480001 | |||||||||
BURNETT, Paul Dennis | Director | 4 Lavendon Court Barton Seagrave NN15 6QH Kettering Northamptonshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 66064990001 | ||||||||
CAMERON, Ian, Mr. | Director | Park Road LE13 1TT Melton Mowbray 26 Leicestershire | England | British | Chartered Surveyor | 164576100001 | ||||||||
GRAHAM, Paul Nigel | Director | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | England | British | Svp Corporate Real Estate | 201355860001 | ||||||||
HOMA, Peter Andrew | Director | 3 Totale Rise Warfield RG42 2PW Bracknell Berkshire | British | Chartered Accountant | 82230400001 | |||||||||
KÜHL, Thorsten | Director | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | Germany | German | Accountant | 252847290001 | ||||||||
LI, Jane | Director | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 134292740003 | ||||||||
NEWSHOLME, Richard John | Director | Gatesgarth Airton BD23 4AL Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | Property Manager | 22195530004 | ||||||||
SEY, Kevin Paul | Director | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 186787040001 | ||||||||
SMEATON, Andrew Faviell | Director | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 2511430001 | ||||||||
SMITH, Jason David | Director | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 120478440001 | ||||||||
TAYLOR, Rebecca Louise Hazel | Director | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | England | British | Accountant | 248396770001 | ||||||||
TURNER, David | Director | c/o Excel Secretarial Services Ltd The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire England | England | British | Chartered Surveyor | 182220870001 | ||||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director corporativo | The Ring RG12 1AQ Bracknell Ocean House Berkshire England |
| 32524900007 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Ms Rebecca Louise Hazel Taylor | 01 jun 2021 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Thorsten Kühl | 05 mar 2020 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: German País de residencia: Germany | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Kevin Paul Sey | 06 abr 2016 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Jason David Smith | 06 abr 2016 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Andrew Faviell Smeaton | 06 abr 2016 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Mrs Jane Li | 06 abr 2016 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
Mr Nigel Paul Graham | 06 abr 2016 | The Ring RG12 1AN Bracknell Ocean House Berkshire United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para COMPASS POINT (ST IVES) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
05 ago 2021 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0