HILLARYS HOLDINGS LIMITED

HILLARYS HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHILLARYS HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04178425
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Unit 2 Churchill Park
    Private Road No 2 Colwick
    NG4 2JR Nottingham
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HILLGATE (223) LIMITED13 mar 200113 mar 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 10 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    1 páginasAA

    Cancelación total de la carga 041784250006

    4 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 10 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Darren Hansel Lock como director el 20 feb 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2017 au 31 dic 2017

    3 páginasAA01

    Resoluciones

    Resolutions
    40 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2016

    1 páginasAA

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Declaración de confirmación presentada el 10 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 oct 2015

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 feb 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 feb 2016

    Estado de capital el 23 feb 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 sept 2014

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 feb 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 feb 2015

    Estado de capital el 17 feb 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Richard Thomas el 03 feb 2015

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Simon Andrew Dalby como director el 28 nov 2014

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Registro de la carga 041784250006, creada el 01 ago 2014

    71 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LEWIS, David Mathew Aubrey
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    Director
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United KingdomAustralian110226830001
    RISMAN, John Matthew
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    Director
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish107350020002
    THOMAS, Andrew Richard
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    England
    Director
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish154618250003
    DOBSON, Kevin Michael
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    Secretario
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    British95476170001
    NICHOLSON, James Brett
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    British99628210001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Secretario designado corporativo
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001
    BURKE, David Richard Andrew
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    Director
    4 Adams Court
    DE7 8YF Ilkeston
    Derbyshire
    British61576180002
    DALBY, Simon Andrew
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110227460002
    DOBSON, Kevin Michael
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    Director
    Highways 3 Grantham Road
    Radcliffe On Trent
    NG12 2HB Nottingham
    United KingdomBritish95476170001
    FERGUSON, Fiona Claire
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    Director
    Cleveland Cottage
    Main Street
    NG23 5BA Claypole
    Nottinghamshire
    British55116100001
    HOLMES, Roger Anthony
    421 Flagstaff House
    10 St George Wharf
    SW8 2LZ Vauxhall London
    Director
    421 Flagstaff House
    10 St George Wharf
    SW8 2LZ Vauxhall London
    United KingdomBritish105159350001
    LOCK, Darren Hansel
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Hillarys Blinds Limited
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131597650005
    NICHOLSON, James Brett
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Laurel House
    351 Mapperly Plains
    NG3 5RS Nottingham
    Nottinghamshire
    British99628210001
    PETROW, Steven
    Flat 2
    48 Lennox Gardens
    SW1X 0DJ London
    Director
    Flat 2
    48 Lennox Gardens
    SW1X 0DJ London
    United KingdomAmerican96100200001
    RUSSO, Lorenzo
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Director
    Flat 19
    17 Eccleston Place
    SW1W 9NF London
    Italian96100220001
    SHANKS, Michael Anthony
    Oakdene
    Main Street
    NG25 0UT Morton
    Nottinghamshire
    Director
    Oakdene
    Main Street
    NG25 0UT Morton
    Nottinghamshire
    British25653690004
    SNAPES, Michael Joseph
    Low Hill Cottage
    Low Hill Road, Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    Director
    Low Hill Cottage
    Low Hill Road, Roydon
    CM19 5JN Harlow
    Essex
    British64079340001
    WILDIG, Simon Roger
    21e Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    Director
    21e Rydens Road
    KT12 3AB Walton On Thames
    Surrey
    British75978900001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Director designado corporativo
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018840001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Director designado corporativo
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HILLARYS HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Unit 2 Churchill Park
    England
    30 jun 2016
    Private Road 2
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2JR Nottingham
    Unit 2 Churchill Park
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUk
    Autoridad legalUk Law
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro262951
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene HILLARYS HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 ago 2014
    Entregado el 04 ago 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ares Management Limited
    Transacciones
    • 04 ago 2014Registro de una carga (MR01)
    • 06 nov 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 21 jun 2007
    Entregado el 02 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the group to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse, London Branch as Agent and Trustee for the Secured Creditors (Security Agent)
    Transacciones
    • 02 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A security agreement
    Creado el 30 jul 2004
    Entregado el 13 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined)
    Creado el 08 may 2001
    Entregado el 22 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the lender under the terms of any finance document (all terms as defined)
    Breve descripción
    All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Investment Partners Limited (The "Security Trustee") as the Generalpartner of Close Brothers Private Equity (UK) Fund Vi (the "Lender")
    Transacciones
    • 22 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust debenture made between (1) the company (2) the obligors and (3) the security trustee (all terms as defined)
    Creado el 08 may 2001
    Entregado el 22 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities (whether actual or contingent) due or to become due from or by any obligor to the security trustee under the terms of any finance document (all terms as defined)
    Breve descripción
    All that freehold land known as units 2 & 3 colwick business park colwick industrial estate mile end colwick nottingham title number NT177997 all that freehold land known as unit 4 colwick business park as aforesaid title number NT179293 all that freehold land known as unit 2 churchill park colwick industrial estate mile end road colwick nottingham title number NT257445 all that freehold land known as units 3 & 4 churchill park as aforesaid title number NT272090 all that freehold land known as land at victoria park netherfield lane netherfield nottingham title number NT327077. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Equity (UK) Fund Vi Acting by Its General Partner Closeinvestment Partners Limited (the "Security Trustee")
    Transacciones
    • 22 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 may 2001
    Entregado el 21 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party under or pursuant to any of the financing documents (including in particular under the guarantee). All terms as defined.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee") Acting as Securitytrustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 21 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0