HDG2018 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHDG2018 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04180966
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HDG2018 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra HDG2018 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HDG2018 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HALLMARK DEVELOPMENTS GROUP LIMITED18 nov 200818 nov 2008
    NEWPORT PROPERTIES LIMITED16 mar 200116 mar 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HDG2018 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HDG2018 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cese del nombramiento de Norman Edward Ewen como director el 18 ene 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Norman Edward Ewen como secretario el 18 ene 2022

    1 páginasTM02

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    19 páginasLIQ14

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Domicilio social registrado cambiado de The Barn Monument Offices Maldon Road Woodham Mortimer, Maldon Essex CM9 6SN a Jupiter House Warley Hill Business Park the Drive Brentwood Essex CM13 3BE el 17 may 2021

    2 páginasAD01

    Declaración de asuntos

    10 páginasLIQ02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 11 mar 2021

    LRESEX

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 ene 2020

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Stephen Derek Everington el 01 jul 2020

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 ene 2019

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Notification de Hallmark Developments (Essex) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 abr 2018

    2 páginasPSC02

    Notification de Hallmark Developments (Essex) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 abr 2018

    2 páginasPSC02

    Cessation de Norman Edward Ewen en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 abr 2018

    1 páginasPSC07

    Cessation de Stephen Derek Everington en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 abr 2018

    1 páginasPSC07

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name15 ago 2018

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 15 ago 2018

    RES15

    Compra de acciones propias.

    3 páginasSH03

    Cese del nombramiento de Barry Andrew Brown como director el 04 abr 2018

    1 páginasTM01

    Cessation de Barry Andrew Brown en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 abr 2018

    1 páginasPSC07

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 jul 2018 au 31 ene 2019

    1 páginasAA01

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 04 abr 2018

    • Capital: GBP 200
    4 páginasSH06

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 jul 2017

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de HDG2018 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EVERINGTON, Stephen Derek
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Director
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish89416910007
    EWEN, Norman Edward
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Secretario
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    British28027870003
    GILBERT, Paul William
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Secretario
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    British10393450001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BROWN, Barry Andrew
    17 Park Rise
    AL5 3AP Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    17 Park Rise
    AL5 3AP Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish81596280001
    EWEN, Norman Edward
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    Director
    Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Jupiter House
    Essex
    EnglandBritish28027870003
    GILBERT, Paul William
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    Director
    7 Parkway
    Gidea Park
    RM2 5NT Romford
    Essex
    EnglandBritish10393450001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HDG2018 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Hallmark Developments (Essex) Limited
    Maldon Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn, Monument Offices
    Essex
    England
    04 abr 2018
    Maldon Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn, Monument Offices
    Essex
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Acts In England & Wales
    Lugar de registroCompanies Register In England & Wales
    Número de registro04744551
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Hallmark Developments (Essex) Ltd
    The Barn, Monument Offices, Maldon Road,
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn
    Essex
    United Kingdom
    04 abr 2018
    The Barn, Monument Offices, Maldon Road,
    Woodham Mortimer
    CM9 6SN Maldon
    The Barn
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Companies In England & Wales
    Número de registro04744551
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Mr Stephen Derek Everington
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 abr 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    Mr Norman Edward Ewen
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 abr 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    Mr Barry Andrew Brown
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    06 abr 2016
    The Barn Monument Offices
    Maldon Road
    CM9 6SN Woodham Mortimer, Maldon
    Essex
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene HDG2018 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of assignment of rental income
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rental income from shop unit 3 roche close rochford.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rental income from shop unit 2 roche close rochford.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rental income from shop unit 1 roche close rochford.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rental income from unit 1 block b roche close rochford.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rental income from unit 2 block b roche close rochford.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rental income from unit 3 block b roche close rochford.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises shop unit 3 roche close rochford (also k/a 7 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises shop unit 2 roche close rochford (also k/a 6 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises shop unit 1 roche close rochford (also k/a 5 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises unit 1 block b roche close rochford (also k/a 3 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises unit 2 block b roche close rochford (also k/a 2 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creado el 12 jul 2010
    Entregado el 15 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H premises unit 3 block b roche close rochford (aslo k/a 1 roche close) all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC
    Transacciones
    • 15 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 06 dic 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 18 nov 2004
    Entregado el 04 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transacciones
    • 04 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 18 nov 2004
    Entregado el 23 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land at the rear of 3-7 heath drive gidea park romford essex t/n EGL446524.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transacciones
    • 23 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene HDG2018 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    11 mar 2021Inicio de la liquidación
    11 abr 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Glyn Mummery
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Profesional
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Paul Atkinson
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Profesional
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0