STADCO HOLDINGS LTD.
Visión general
| Nombre de la empresa | STADCO HOLDINGS LTD. |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04215953 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de STADCO HOLDINGS LTD.?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra STADCO HOLDINGS LTD.?
| Dirección de la sede social | International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| OFFSHELF 282 LTD | 14 may 2001 | 14 may 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de STADCO HOLDINGS LTD.?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para STADCO HOLDINGS LTD.?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 15 oct 2019
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark John Smith el 18 abr 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christopher Paul Fisher el 18 abr 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW a International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE el 07 oct 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark John Smith como secretario el 05 sept 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Hayhurst como secretario el 05 sept 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Mark John Smith como director el 30 nov 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Paul Fisher como director el 30 nov 2015 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gregory Ian Macleod como director el 30 oct 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Gordon Hussey como director el 30 nov 2015 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL a Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW el 29 dic 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 042159530006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Mark John | Secretario | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | 213570940001 | |||||||
| FISHER, Christopher Paul | Director | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 183747270001 | |||||
| SMITH, Mark John | Director | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | United Kingdom | British | 124719430001 | |||||
| HAYHURST, Michael | Secretario | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | British | 15201970002 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Secretario | Plas Onn Quinta Weston Rhyn SY10 7LW Oswestry Shropshire | British | 10529040001 | ||||||
| OTHERS INTERESTS LTD | Secretario corporativo | Churchill House 47 Regent Road ST1 3RQ Stoke On Trent Staffordshire | 103784950001 | |||||||
| COOK, Jonathan Charles | Director | The Backs 38 South Parade, Harbury CV33 9JE Leamington Spa Warwickshire | British | 72559760001 | ||||||
| HUSSEY, David Gordon | Director | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | England | British | 131639570002 | |||||
| HUSSEY, David Gordon | Director | Callingwood Lane Tatenhill DE13 9SH Burton-On-Trent Callingwood Hall Staffordshire United Kingdom | British | 131639570001 | ||||||
| KYNASTON, Stephen Lloyd | Director | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | United Kingdom | British | 10529040001 | |||||
| MACLEOD, Gregory Ian | Director | 5 Apollo Way CV34 6RW Warwick Tachbrook Park Warwickshire | United Kingdom | Australian | 60518160005 | |||||
| MORGAN, Kelvin Brian | Director | Manderley Ellesmere Road Harmer Hill SY4 3EE Shrewsbury Shropshire | England | British | 74818010001 | |||||
| MORGAN, Kelvin Brian | Director | Manderley Ellesmere Road Harmer Hill SY4 3EE Shrewsbury Shropshire | England | British | 74818010001 | |||||
| MORRISS, Andrew Stuart | Director | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | England | British | 11643310001 | |||||
| ROACHE, David John | Director | Fallowfield Badgers Lane CV35 0BY Lower Tysoe Warwickshire | United Kingdom | British | 40953790002 | |||||
| STERNE, Dermot Desmond | Director | Harlescott Lane Shrewsbury SY1 3AS Shropshire | Uk | British | 96569780001 | |||||
| SWORD, John David | Director | Chivel OX7 5TR Chipping Norton Oxfordshire | England | British | 1600540001 | |||||
| WILLIS, David John | Director | Damson Cottage Highfields SY4 5UN Wem Shropshire | British | 51085590002 | ||||||
| YOUENS, Michael Arthur | Director | 14 Westwood Drive The Mount SY3 8YB Shrewsbury Shropshire | British | 36008490001 | ||||||
| OFFSHELF LTD | Director corporativo | Churchill House 47 Regent Road ST1 3RQ Stoke On Trent Staffordshire | 42228870001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de STADCO HOLDINGS LTD.?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acertec Engineering Limited | 06 abr 2016 | Siskin Parkway East Middlemarch Business Park CV3 4PE Coventry International House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene STADCO HOLDINGS LTD. alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 29 ago 2013 Entregado el 06 sept 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 29 ago 2013 Entregado el 04 sept 2013 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 23 nov 2005 Entregado el 01 dic 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge | Creado el 28 feb 2003 Entregado el 06 mar 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 28 feb 2003 Entregado el 06 mar 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Pledge of shares | Creado el 23 jul 2002 Entregado el 07 ago 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción 926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental deed to the target group debenture | Creado el 23 jul 2002 Entregado el 07 ago 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0