STADCO HOLDINGS LTD.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTADCO HOLDINGS LTD.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04215953
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STADCO HOLDINGS LTD.?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra STADCO HOLDINGS LTD.?

    Dirección de la sede social
    International House Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de STADCO HOLDINGS LTD.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OFFSHELF 282 LTD14 may 200114 may 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STADCO HOLDINGS LTD.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STADCO HOLDINGS LTD.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 15 oct 2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 08 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Mark John Smith el 18 abr 2019

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Christopher Paul Fisher el 18 abr 2019

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW a International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PE el 07 oct 2016

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Mark John Smith como secretario el 05 sept 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Hayhurst como secretario el 05 sept 2016

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 08 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 may 2016

    Estado de capital el 09 may 2016

    • Capital: GBP 19,155,439
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    20 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark John Smith como director el 30 nov 2015

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Christopher Paul Fisher como director el 30 nov 2015

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gregory Ian Macleod como director el 30 oct 2015

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Gordon Hussey como director el 30 nov 2015

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL a Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW el 29 dic 2015

    2 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 042159530006

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de STADCO HOLDINGS LTD.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Secretario
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    213570940001
    FISHER, Christopher Paul
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Director
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish183747270001
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    Director
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish124719430001
    HAYHURST, Michael
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Secretario
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    British15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    Secretario
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    British10529040001
    OTHERS INTERESTS LTD
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secretario corporativo
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    103784950001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    HUSSEY, David Gordon
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Director
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    EnglandBritish131639570002
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    British131639570001
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Director
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    United KingdomBritish10529040001
    MACLEOD, Gregory Ian
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    Director
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    United KingdomAustralian60518160005
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Director
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    EnglandBritish11643310001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Director
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritish40953790002
    STERNE, Dermot Desmond
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    Director
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    UkBritish96569780001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Director
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish1600540001
    WILLIS, David John
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    Director
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    British51085590002
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001
    OFFSHELF LTD
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director corporativo
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    42228870001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STADCO HOLDINGS LTD.?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    06 abr 2016
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro555532
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene STADCO HOLDINGS LTD. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 29 ago 2013
    Entregado el 06 sept 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Board of the Pension Protection Fund
    Transacciones
    • 06 sept 2013Registro de una carga (MR01)
    • 16 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 29 ago 2013
    Entregado el 04 sept 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 04 sept 2013Registro de una carga (MR01)
    • 16 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 23 nov 2005
    Entregado el 01 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC 'Security Trustee'
    Transacciones
    • 01 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 16 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge
    Creado el 28 feb 2003
    Entregado el 06 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 feb 2003
    Entregado el 06 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 10 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge of shares
    Creado el 23 jul 2002
    Entregado el 07 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Known as Chase Manhattan International Limited) or Theother Finance Parties
    Transacciones
    • 07 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 11 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed to the target group debenture
    Creado el 23 jul 2002
    Entregado el 07 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly K/a Chase Manhattan International Limited)
    Transacciones
    • 07 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 11 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0