ATHORPE HEALTH CARE LIMITED

ATHORPE HEALTH CARE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaATHORPE HEALTH CARE LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04216853
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?

    • Establecimientos residenciales de cuidados de enfermería (87100) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    New Burlington House
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta14 dic 2026
    Próxima declaración de confirmación vence28 dic 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta14 dic 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Registro de la carga 042168530003, creada el 27 feb 2026

    57 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Daniel Markovic como director el 05 nov 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Paul John Milner como director el 05 nov 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Oliver Paul Milner como director el 05 nov 2025

    1 páginasTM01

    Modification des détails de Dinnington Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 nov 2025

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de The Dairy, Criftin Enterprise Centre Oxton Road Epperstone Nottingham NG14 6AT England a New Burlington House 1075 Finchley Road London NW11 0PU el 01 dic 2025

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025

    9 páginasAA

    Comptes modifiés pour une petite entreprise établis au 31 mar 2024

    6 páginasAAMD

    Cese del nombramiento de Simone Cheryl Wells como director el 06 oct 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 02 may 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 may 2024 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Notification de Dinnington Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 may 2024

    2 páginasPSC02

    Cessation de Conniston Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 may 2024

    1 páginasPSC07

    Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Conniston Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2023

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mr Oliver Paul Milner como director el 09 may 2022

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 042168530002, creada el 03 mar 2022

    4 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Nombramiento de Mr Paul John Milner como director el 02 dic 2021

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MARKOVIC, Daniel
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    New Burlington House
    England
    Director
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    New Burlington House
    England
    United KingdomBritish85466710003
    CLARKSON, Tracy
    3 Mawfa Avenue
    S14 1AJ Sheffield
    Secretario
    3 Mawfa Avenue
    S14 1AJ Sheffield
    British126509210001
    CRAIG, Euan David
    31 Conduit Road
    S10 1EW Sheffield
    Secretario
    31 Conduit Road
    S10 1EW Sheffield
    British88503230002
    MALLETT, Keith
    12 Appleby Place
    Skellow
    DN6 8NP Doncaster
    South Yorkshire
    Secretario
    12 Appleby Place
    Skellow
    DN6 8NP Doncaster
    South Yorkshire
    British75910800001
    QUARRINGTON, Julie
    15 Tattersett Road
    Syderstone
    PE31 8SA Kings Lynn
    Norfolk
    Secretario
    15 Tattersett Road
    Syderstone
    PE31 8SA Kings Lynn
    Norfolk
    British66890990002
    CLARKSON, Tracy Jo-Anne
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    Director
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    United KingdomBritish149324610001
    COLLINGE, Damian
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    Director
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    EnglandBritish161678570001
    CRAIG, Euan David
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    Director
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    EnglandBritish163014590001
    CUNNINGHAM, Guy Bradley
    259 Morthen Road
    Wickersley
    S66 1DY Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    259 Morthen Road
    Wickersley
    S66 1DY Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritish95762420001
    CUNNINGHAM, Susan Dawn
    Morthen Road
    Wickersley
    S66 1DY Rotherham
    259
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Morthen Road
    Wickersley
    S66 1DY Rotherham
    259
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish138688520001
    DEVENPORT, Julie
    8 Pessall Lane
    Edingale
    B79 9JN Tamworth
    Staffordshire
    Director
    8 Pessall Lane
    Edingale
    B79 9JN Tamworth
    Staffordshire
    British106824970001
    DUKE, Trudy
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    Director
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    EnglandBritish140740470001
    DYSON, Neil
    15 Tattersett Road
    Syderstone
    PE31 8SA Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    15 Tattersett Road
    Syderstone
    PE31 8SA Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandBritish169560320001
    FOXALL, Kerris
    118 Penkhull New Road
    Penkhull
    ST4 5DG Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    118 Penkhull New Road
    Penkhull
    ST4 5DG Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish81363200001
    KING, Richard
    Ferham House
    Kimberworth Road Masbrough
    S61 1AJ Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    Ferham House
    Kimberworth Road Masbrough
    S61 1AJ Rotherham
    South Yorkshire
    United KingdomBritish165897680001
    MELLA-RUA, Christine Alison
    Old Chapel House
    Rowthorne Lane Glapwell
    S44 5QF Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Old Chapel House
    Rowthorne Lane Glapwell
    S44 5QF Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish107869550002
    MILNER, Alison Jayne
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    Director
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    EnglandBritish91641960003
    MILNER, Oliver Paul
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    New Burlington House
    England
    Director
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    New Burlington House
    England
    United KingdomBritish286345260001
    MILNER, Paul John
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    New Burlington House
    England
    Director
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    New Burlington House
    England
    United KingdomBritish91641870005
    MILNER, Paul John
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    Director
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    United KingdomBritish250459760001
    QUARRINGTON, Julie
    15 Tattersett Road
    Syderstone
    PE31 8SA Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    15 Tattersett Road
    Syderstone
    PE31 8SA Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandBritish66890990002
    ROWE-BEWICK, David
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    Director
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    United KingdomBritish185125250001
    STORR, Christine
    24 Ashdell Road
    Broomhill
    S10 3DA Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    24 Ashdell Road
    Broomhill
    S10 3DA Sheffield
    South Yorkshire
    British81360770001
    TAYLOR, Karen Vivien
    The Farmhouse
    Aldham Mill Barnsley Road
    S73 8EG Wombwell
    South Yorkshire
    Director
    The Farmhouse
    Aldham Mill Barnsley Road
    S73 8EG Wombwell
    South Yorkshire
    United KingdomBritish120510920001
    TAYLOR, Karen Vivien
    The Farmhouse
    Aldham Mill Barnsley Road
    S73 8EG Wombwell
    South Yorkshire
    Director
    The Farmhouse
    Aldham Mill Barnsley Road
    S73 8EG Wombwell
    South Yorkshire
    United KingdomBritish120510920001
    THOMAS, Lisa Jayne
    Park Lane
    Burton Waters
    LN1 2YZ Lincoln
    115
    Director
    Park Lane
    Burton Waters
    LN1 2YZ Lincoln
    115
    ScotlandBritish138694230001
    WATSON, Serena
    Greenwood Avenue
    Upton
    WF9 1NS Pontefract
    10
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Greenwood Avenue
    Upton
    WF9 1NS Pontefract
    10
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British138688530001
    WELLS, Simone Cheryl
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    Director
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Dairy, Criftin Enterprise Centre
    England
    EnglandBritish199988760001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Dinnington Care Limited
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    New Burlington House
    England
    02 may 2024
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    New Burlington House
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro13766469
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Bcl Management Limited
    Lancaster Road
    Carnaby
    YO15 3QY Bridlington
    Lancaster House
    England
    17 oct 2017
    Lancaster Road
    Carnaby
    YO15 3QY Bridlington
    Lancaster House
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland & Wales
    Número de registro10928907
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    Conniston Care Limited
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Diary, Criftin Enterprise Centre
    England
    06 abr 2016
    Oxton Road
    Epperstone
    NG14 6AT Nottingham
    The Diary, Criftin Enterprise Centre
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro05872949
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0