ATHORPE HEALTH CARE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ATHORPE HEALTH CARE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04216853 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?
- Establecimientos residenciales de cuidados de enfermería (87100) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?
| Dirección de la sede social | New Burlington House 1075 Finchley Road NW11 0PU London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 14 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 28 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 14 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Registro de la carga 042168530003, creada el 27 feb 2026 | 57 páginas | MR01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Daniel Markovic como director el 05 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Paul John Milner como director el 05 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Oliver Paul Milner como director el 05 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Dinnington Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 nov 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Dairy, Criftin Enterprise Centre Oxton Road Epperstone Nottingham NG14 6AT England a New Burlington House 1075 Finchley Road London NW11 0PU el 01 dic 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2025 | 9 páginas | AA | ||
Comptes modifiés pour une petite entreprise établis au 31 mar 2024 | 6 páginas | AAMD | ||
Cese del nombramiento de Simone Cheryl Wells como director el 06 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 9 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 02 may 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Notification de Dinnington Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 may 2024 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Conniston Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 may 2024 | 1 páginas | PSC07 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Conniston Care Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mar 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 8 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Oliver Paul Milner como director el 09 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Registro de la carga 042168530002, creada el 03 mar 2022 | 4 páginas | MR01 | ||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||
Nombramiento de Mr Paul John Milner como director el 02 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKOVIC, Daniel | Director | 1075 Finchley Road NW11 0PU London New Burlington House England | United Kingdom | British | 85466710003 | |||||
| CLARKSON, Tracy | Secretario | 3 Mawfa Avenue S14 1AJ Sheffield | British | 126509210001 | ||||||
| CRAIG, Euan David | Secretario | 31 Conduit Road S10 1EW Sheffield | British | 88503230002 | ||||||
| MALLETT, Keith | Secretario | 12 Appleby Place Skellow DN6 8NP Doncaster South Yorkshire | British | 75910800001 | ||||||
| QUARRINGTON, Julie | Secretario | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | British | 66890990002 | ||||||
| CLARKSON, Tracy Jo-Anne | Director | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Dairy, Criftin Enterprise Centre England | United Kingdom | British | 149324610001 | |||||
| COLLINGE, Damian | Director | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Dairy, Criftin Enterprise Centre England | England | British | 161678570001 | |||||
| CRAIG, Euan David | Director | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Dairy, Criftin Enterprise Centre England | England | British | 163014590001 | |||||
| CUNNINGHAM, Guy Bradley | Director | 259 Morthen Road Wickersley S66 1DY Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 95762420001 | |||||
| CUNNINGHAM, Susan Dawn | Director | Morthen Road Wickersley S66 1DY Rotherham 259 South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 138688520001 | |||||
| DEVENPORT, Julie | Director | 8 Pessall Lane Edingale B79 9JN Tamworth Staffordshire | British | 106824970001 | ||||||
| DUKE, Trudy | Director | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Dairy, Criftin Enterprise Centre England | England | British | 140740470001 | |||||
| DYSON, Neil | Director | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | England | British | 169560320001 | |||||
| FOXALL, Kerris | Director | 118 Penkhull New Road Penkhull ST4 5DG Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 81363200001 | |||||
| KING, Richard | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 165897680001 | |||||
| MELLA-RUA, Christine Alison | Director | Old Chapel House Rowthorne Lane Glapwell S44 5QF Chesterfield Derbyshire | England | British | 107869550002 | |||||
| MILNER, Alison Jayne | Director | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Dairy, Criftin Enterprise Centre England | England | British | 91641960003 | |||||
| MILNER, Oliver Paul | Director | 1075 Finchley Road NW11 0PU London New Burlington House England | United Kingdom | British | 286345260001 | |||||
| MILNER, Paul John | Director | 1075 Finchley Road NW11 0PU London New Burlington House England | United Kingdom | British | 91641870005 | |||||
| MILNER, Paul John | Director | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Dairy, Criftin Enterprise Centre England | United Kingdom | British | 250459760001 | |||||
| QUARRINGTON, Julie | Director | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | England | British | 66890990002 | |||||
| ROWE-BEWICK, David | Director | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Dairy, Criftin Enterprise Centre England | United Kingdom | British | 185125250001 | |||||
| STORR, Christine | Director | 24 Ashdell Road Broomhill S10 3DA Sheffield South Yorkshire | British | 81360770001 | ||||||
| TAYLOR, Karen Vivien | Director | The Farmhouse Aldham Mill Barnsley Road S73 8EG Wombwell South Yorkshire | United Kingdom | British | 120510920001 | |||||
| TAYLOR, Karen Vivien | Director | The Farmhouse Aldham Mill Barnsley Road S73 8EG Wombwell South Yorkshire | United Kingdom | British | 120510920001 | |||||
| THOMAS, Lisa Jayne | Director | Park Lane Burton Waters LN1 2YZ Lincoln 115 | Scotland | British | 138694230001 | |||||
| WATSON, Serena | Director | Greenwood Avenue Upton WF9 1NS Pontefract 10 West Yorkshire United Kingdom | British | 138688530001 | ||||||
| WELLS, Simone Cheryl | Director | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Dairy, Criftin Enterprise Centre England | England | British | 199988760001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ATHORPE HEALTH CARE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinnington Care Limited | 02 may 2024 | 1075 Finchley Road NW11 0PU London New Burlington House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Bcl Management Limited | 17 oct 2017 | Lancaster Road Carnaby YO15 3QY Bridlington Lancaster House England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Conniston Care Limited | 06 abr 2016 | Oxton Road Epperstone NG14 6AT Nottingham The Diary, Criftin Enterprise Centre England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0