XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04220043 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Kroll Advisory Ltd, The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PRO-CUR SERVICES LIMITED | 04 dic 2001 | 04 dic 2001 |
| PRO-CUR OPCO LIMITED | 15 jun 2001 | 15 jun 2001 |
| PURPLEBRIGHT LIMITED | 21 may 2001 | 21 may 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Neal Halbard como director el 01 abr 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom a Kroll Advisory Ltd, the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG el 19 dic 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2022 au 30 sept 2022 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven James Turpie como director el 15 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 mar 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Segunda presentación para el nombramiento de Hugo Martin Eales como director | 6 páginas | RP04AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Hugo Martin Eales como director el 21 ene 2022 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital el 29 sept 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 10 ago 2021
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Steven James Turpie el 28 abr 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Christopher Neal Halbard el 31 mar 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 mar 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Csc Computer Sciences International Operations Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 abr 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Neal Halbard como director el 07 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tina Anne Gough como director el 07 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EALES, Hugo Martin | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Kroll Advisory Ltd, The Shard | United Kingdom | British | 291919480001 | |||||
| WOODFINE, Michael Charles | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Kroll Advisory Ltd, The Shard | England | British | 208597210001 | |||||
| DAVIES, John Graeme | Secretario | Airlie Roberts Lane, Chalfont St. Peter SL9 0QR Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 72253030004 | ||||||
| GALLAGHER, Anthony James | Secretario | 13 Hanover Square London W1S 1HN | Irish | 127048740001 | ||||||
| MARTIN, Nicola Jane | Secretario | 1 Sonic Court Woodbridge Road GU1 1DZ Guildford Surrey | British | 90604420002 | ||||||
| MILLER, Marian Alison | Secretario | 122a Fleet Road GU14 9RG Farnborough Hampshire | British | 117767070001 | ||||||
| PARKES, David Stanley | Secretario | Bark Hart Tilford Road Beacon Hill GU26 6RQ Hindhead Surrey | British | 25179240002 | ||||||
| SHERWOOD EDWARDS, Mark | Secretario | 41 Palmerston Road SW14 7QA London | British | 75687820001 | ||||||
| SHERWOOD EDWARDS, Mark | Secretario | 41 Palmerston Road SW14 7QA London | British | 75687820001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| ANDRE, John Paul | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 165772840001 | |||||
| ANDREWS, David William | Director | 30 Hill Street Mayfair W1J 5NW London | British | 113894730001 | ||||||
| ARMITAGE, Michael Russell | Director | The Covert 30 Ling Drive GU18 5PA Lightwater Surrey | England | British | 78726630001 | |||||
| BATTY, Michael James | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 136863390001 | |||||
| BAUERNFEIND, David Gregory | Director | Leadenhall Street EC4A 1AX London 34 United Kingdom | United Kingdom | British | 99529910001 | |||||
| BAYLIFFE, Stephen Patrick John | Director | Leyland Bridge Barn Lea Road PR2 1RZ Preston | British | 113276820002 | ||||||
| BESTER, Andrew John Milton | Director | 18a Copsem Lane KT10 9HB Esher Surrey | South African | 85290370001 | ||||||
| BHAT, Guruprasad | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | India | Indian | 201267650001 | |||||
| BOURNE, Ann Susan | Director | School House Farm Preston Road PR4 0TT Inskip Preston Lancashire England | British | 59016700002 | ||||||
| BOUVIER, Stephane | Director | 5 Molteno Road WD17 4UD Watford Hertfordshire | French | 107899560001 | ||||||
| BYRNE, Patrick Michael | Director | Leadenhall Street EC4A 1AX London 34 United Kingdom | United Kingdom | British | 127876200001 | |||||
| CROOM, Timothy Llewellyn | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | United Kingdom | British | 184906470001 | |||||
| CROSS, David Edward Guy | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | England | British | 194433740001 | |||||
| DREGHORN, Patricia Ann | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 194625930001 | |||||
| FORD, Nicholas | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 141096730001 | |||||
| GOUGH, Tina Anne | Director | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 229756300001 | |||||
| GRAY, David William Hart | Director | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 224241390001 | |||||
| GREEN, Malcolm Frederick, Dr | Director | White Gates Shire Lane, Chorleywood WD3 5NT Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 28054420001 | |||||
| HALBARD, Christopher Neal | Director | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Kroll Advisory Ltd, The Shard | United Kingdom | British | 152748570001 | |||||
| HOUGHTON, Richard Alexander | Director | 13 Hanover Square London W1S 1HN | England | Irish | 119279790001 | |||||
| HOUGHTON, Richard Alexander | Director | 4 The Quillot Burwood Park KT12 5BY Walton On Thames Surrey | England | Irish | 119279790001 | |||||
| HOUGHTON, Richard Alexander | Director | 4 The Quillot Burwood Park KT12 5BY Walton On Thames Surrey | England | Irish | 119279790001 | |||||
| IERLAND, Brian William | Director | 8 Sawyers Close Wraxall BS48 1LY Bristol | British | 90349460001 | ||||||
| IMRIE, Alastair Milne | Director | The Old Parsonage SK14 6JN Mottram In Longdendale Cheshire | United Kingdom | British | 82055150001 | |||||
| KUSNERAITIS, Christian Neil | Director | 25 Walbrook EC4N 8AQ London The Walbrook Building | United Kingdom | British | 287505540001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dxc Uk International Operations Limited | 09 dic 2019 | Wellesley Road GU11 1P2 Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Xchanging Limited | 03 may 2018 | Wellesley Road GU11 1PZ Aldershot Royal Pavilion Hampshire United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Xchanging Procurement Services (Holdco) Limited | 21 nov 2016 | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 20 nov 2016 | 20 nov 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que existe una persona registrable en relación con la empresa, pero no la ha identificado. |
¿Tiene XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Creado el 28 oct 2011 Entregado el 09 nov 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 19 february 2007 and | Creado el 30 jul 2007 Entregado el 17 ago 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement dated 19/02/2007 and | Creado el 02 jul 2007 Entregado el 05 jul 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of admission | Creado el 20 mar 2007 Entregado el 26 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due of each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene XCHANGING PROCUREMENT SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0