LA TASCA GROUP LIMITED

LA TASCA GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLA TASCA GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04220541
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LA TASCA GROUP LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra LA TASCA GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Lower Ground Floor, Elsley House
    24/30 Great Titchfield Street
    W1W 8BF London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LA TASCA GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE RESTAURANT PEOPLE GROUP LIMITED27 jul 200127 jul 2001
    DMWSL 339 LIMITED21 may 200121 may 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LA TASCA GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta26 may 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LA TASCA GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Cese del nombramiento de James Forrester Spragg como director el 31 mar 2021

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 1st Floor, 163 Eversholt Street London NW1 1BU England a Lower Ground Floor, Elsley House 24/30 Great Titchfield Street London W1W 8BF el 10 mar 2021

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 21 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 may 2019

    2 páginasAA

    Registro de la carga 042205410015, creada el 14 ene 2020

    24 páginasMR01

    Nombramiento de Mr Adrian Walker como director el 06 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Giles Matthew Oliver David como secretario el 06 dic 2019

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Giles Matthew Oliver David como director el 06 dic 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 21 may 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr James Forrester Spragg como director el 30 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Richards como director el 30 abr 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 may 2018

    2 páginasAA

    Registro de la carga 042205410014, creada el 15 ago 2018

    25 páginasMR01

    Registro de la carga 042205410013, creada el 15 ago 2018

    25 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 21 may 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 may 2017

    2 páginasAA

    Notification de La Tasca Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 may 2017

    2 páginasPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 06 mar 2018

    2 páginasPSC09

    Cese del nombramiento de Timothy John Doubleday como director el 21 jun 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Giles Matthew Oliver David como secretario el 21 jun 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy John Doubleday como secretario el 21 jun 2017

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de LA TASCA GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WALKER, Adrian Rowland
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish265227060001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor, 163
    England
    Secretario
    Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor, 163
    England
    237559790001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Secretario
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    201021490001
    EVANS, Martin John
    6 Bellcast Close
    Appleton
    WA4 5SA Warrington
    Cheshire
    Secretario
    6 Bellcast Close
    Appleton
    WA4 5SA Warrington
    Cheshire
    British52869850002
    POWELL, Matthew David
    33 Tagg Wood View
    Ramsbottom
    BL0 9XP Bury
    Lancashire
    Secretario
    33 Tagg Wood View
    Ramsbottom
    BL0 9XP Bury
    Lancashire
    British125692100001
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    MAZARS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Bridge House,
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Bridge House,
    St Katharine's Way
    E1W 1DD London
    Tower
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro759664
    130398850001
    ABBEY, Adrian Mark
    The Stables
    Mill Lane Broom
    B50 4HS Alcester
    Warwickshire
    Director
    The Stables
    Mill Lane Broom
    B50 4HS Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish78951280002
    ARMOUR, Malcolm Craig
    104 Trinity Road
    EH5 3JZ Edinburgh
    Midlothian
    Director
    104 Trinity Road
    EH5 3JZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish70810590001
    BAKER, Suzanne Louise
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    Director
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    EnglandBritish35409580006
    BARNES, Michael John
    28 Old Lane
    Bramhope
    LS16 9AZ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    28 Old Lane
    Bramhope
    LS16 9AZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish11951630001
    BROWN, Aaron Maxwell
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    Director
    Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    5
    United KingdomBritish98928830002
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor, 163
    England
    Director
    Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor, 163
    England
    EnglandBritish187907210001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    EDWARD, Ian
    17 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    Director
    17 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    EnglandBritish90337160001
    EVANS, Martin John
    6 Bellcast Close
    Appleton
    WA4 5SA Warrington
    Cheshire
    Director
    6 Bellcast Close
    Appleton
    WA4 5SA Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish52869850002
    GRUNNELL, Mark
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    Director
    Montolieu Gardens
    SW15 6PB London
    3
    United KingdomBritish94144450002
    HAVENHAND, Jonathan
    20 Canterbury Avenue
    Fulwood
    S10 3RT Sheffield
    Yorkshire
    Director
    20 Canterbury Avenue
    Fulwood
    S10 3RT Sheffield
    Yorkshire
    British80812860002
    HORLER, James Michael Alexander
    West End Farm
    Main Street
    WR11 7UE Sedgeberrow
    Worcestershire
    Director
    West End Farm
    Main Street
    WR11 7UE Sedgeberrow
    Worcestershire
    British65293140002
    KEEN, Christian
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    Director
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    United KingdomBritish117424240001
    MCLAUGHLIN, Mary Catherine
    The Cobbles
    Donkey Lane
    SK9 1PX Wilmslow
    Cheshire
    Director
    The Cobbles
    Donkey Lane
    SK9 1PX Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomIrish58320700002
    MYERS, David Paul
    Glyme Court
    Oxford Office Village Off Langford Lane
    OX5 1LQ Kidlington
    County House
    Oxford
    United Kingdom
    Director
    Glyme Court
    Oxford Office Village Off Langford Lane
    OX5 1LQ Kidlington
    County House
    Oxford
    United Kingdom
    EnglandBritish142171370001
    POWELL, Matthew David
    33 Tagg Wood View
    Ramsbottom
    BL0 9XP Bury
    Lancashire
    Director
    33 Tagg Wood View
    Ramsbottom
    BL0 9XP Bury
    Lancashire
    EnglandBritish125692100001
    RICHARDS, Stephen
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish187618040002
    RICHARDSON, Richard William
    16 Pecketts Way
    HG1 3EW Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    16 Pecketts Way
    HG1 3EW Harrogate
    North Yorkshire
    British31914560002
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Director
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    SPRAGG, James Forrester
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Director
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish127602840002
    SYMONDS, Paul
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Director
    Willow House
    10a Vicars Close, Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish80167420001
    WETTON, Gavin
    Kingfisher Way
    Cottenham
    CB24 8XN Cambridge
    30
    Cambridgeshire
    Director
    Kingfisher Way
    Cottenham
    CB24 8XN Cambridge
    30
    Cambridgeshire
    EnglandBritish141080490001
    WILKINSON, Simon
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Director
    500 Capability Green
    LU1 3LS Luton
    Porter Tun House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158424890001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Director corporativo
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LA TASCA GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    21 may 2017
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07505029
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para LA TASCA GROUP LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    21 may 201721 may 2017La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene LA TASCA GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 14 ene 2020
    Entregado el 16 ene 2020
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transacciones
    • 16 ene 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 15 ago 2018
    Entregado el 23 ago 2018
    Pendiente
    Breve descripción
    None at the date of the charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transacciones
    • 23 ago 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 15 ago 2018
    Entregado el 23 ago 2018
    Pendiente
    Breve descripción
    All current and future interests in property and intellectual property owned by the company, in each case as defined in the supplemental debenture registered by this form MR01. For more details please refer to the supplemental debenture.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 23 ago 2018Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 05 feb 2016
    Entregado el 12 feb 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transacciones
    • 12 feb 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 25 sept 2015
    Entregado el 05 oct 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transacciones
    • 05 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 19 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 25 sept 2015
    Entregado el 02 oct 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 02 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 19 feb 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 24 feb 2011
    Entregado el 28 feb 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each obligor and bay restaurant holdings limited and la tasca, inc to the security trustee or to any of the other secured parties or any other finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Commerzbank Ag Filiale Luxemburg
    Transacciones
    • 28 feb 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 12 sept 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 27 mar 2008
    Entregado el 03 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the parent and each obligor of la tasca, inc to the chargee or to any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Kaupthing Bank Hf, Kaupthing Singer and Friedlander LTD, Dresdner Bank Ag London Branch, Simon Appell and Alastair Beveridge Each of Kroll Limited and Others
    Transacciones
    • 03 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 06 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignment of keyman life policy
    Creado el 07 nov 2002
    Entregado el 22 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations); and the assignor's whole right title and interest present and future in the policy. The policy of life assurance on the life of michael john barnes with scottish equitable PLC (policy number LO0191147322) dated 30 september 2002.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee") as Security Trusteefor Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transacciones
    • 22 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creado el 23 ago 2002
    Entregado el 11 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy of life assurance on the life of james michael alexander horler with scottish equitable PLC (policy number LO199333112) dated 16TH november 2001 all sums assured by it and all bonuses and benefits accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transacciones
    • 11 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creado el 23 ago 2002
    Entregado el 11 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy of life assurance on the life of jonathan havenhand with norwich union linked life assurance (policy number 7748495EG) dated 18TH june 2002 all sums assured by it and all bonuses and benefits accruing therefrom.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transacciones
    • 11 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creado el 23 ago 2002
    Entregado el 11 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy of life assurance on the life of mary catherine mclaughlin with norwich union linked life assurance limited (policy number 7784177EL) dated 15TH april 2002 all sums assured by it and all bo. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transacciones
    • 11 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creado el 23 ago 2002
    Entregado el 11 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy of life assurance on the life of martin john evans with norwich union linked life assurance limited (policy number 7784384EU) dated 5TH april 2002 and all bonuses and benefits accruing ther. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for Itself and Each of the Security Beneficiaries
    Transacciones
    • 11 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creado el 13 feb 2002
    Entregado el 16 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy of life insurance on the life of michael john barnes with scottish equitable (policy number L0196780902), all sums assured by it and all bonuses and benefits wich may arise under it.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 sept 2001
    Entregado el 13 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and to the holders of the secured consideration loan notes under the secured consideration loan notes (as defined therein) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0