FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04235234 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED?
- Establecimientos residenciales de cuidados de enfermería (87100) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Exemplar Health Care Support Centre 17 Europa View S9 1XH Sheffield England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| FAIRBURN HEALTH CARE (MEWS) LIMITED | 27 oct 2004 | 27 oct 2004 |
| FAIRBURN HEALTH CARE LIMITED | 05 sept 2003 | 05 sept 2003 |
| EXEMPLAR DEVELOPMENTS LIMITED | 15 jun 2001 | 15 jun 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 28 mar 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 11 abr 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 28 mar 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 28 páginas | AA | ||
Cambio de datos del secretario Mrs Elizabeth Jane Pancott el 22 jul 2025 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Mrs Elizabeth Jane Pancott el 22 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Exemplar Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 abr 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Ferham House Kimberworth Road Masbrough Rotherham South Yorkshire S61 1AJ a Exemplar Health Care Support Centre 17 Europa View Sheffield S9 1XH el 10 abr 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Helen Baxendale como director el 03 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 27 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Miss Elizabeth Jane Phipps el 08 feb 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Elizabeth Jane Phipps el 08 feb 2024 | 1 páginas | CH03 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 32 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Renuncia del auditor | 1 páginas | AUD | ||
Cese del nombramiento de Lynne Waters como director el 18 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 23 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Steven Andrew Melton como director el 01 nov 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de John Henry Whitehead como director el 01 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 25 páginas | AA | ||
Cancelación total de la carga 042352340010 | 1 páginas | MR04 | ||
Nombramiento de Mr Angus John Blyth como director el 11 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANCOTT, Elizabeth Jane | Secretario | 17 Europa View S9 1XH Sheffield Exemplar Health Care Support Centre England | 245130670002 | |||||||
| BLYTH, Angus John | Director | 17 Europa View S9 1XH Sheffield Exemplar Health Care Support Centre England | England | British | 271931050001 | |||||
| MELTON, Steven Andrew | Director | 17 Europa View S9 1XH Sheffield Exemplar Health Care Support Centre England | England | British | 289191220001 | |||||
| PANCOTT, Elizabeth Jane | Director | 17 Europa View S9 1XH Sheffield Exemplar Health Care Support Centre England | England | British | 333826340001 | |||||
| CLARKSON, Tracy | Secretario | 3 Mawfa Avenue S14 1AJ Sheffield | British | 126509210001 | ||||||
| CRAIG, Euan David | Secretario | 31 Conduit Road S10 1EW Sheffield | British | 88503230002 | ||||||
| MALLETT, Keith | Secretario | 12 Appleby Place Skellow DN6 8NP Doncaster South Yorkshire | British | 75910800001 | ||||||
| PATUREL, Benoit Julien Mathieu | Secretario | 7 Upper Wimpole Street W1G 6LQ London | French | 64550070001 | ||||||
| QUARRINGTON, Julie | Secretario | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | British | 66890990002 | ||||||
| BAXENDALE, Helen | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 260484140001 | |||||
| CLARKSON, Tracy Jo-Anne | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 149324610001 | |||||
| COLLINGE, Damian | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 161678570001 | |||||
| CRAIG, Euan David | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 163014590001 | |||||
| CUNNINGHAM, Guy Bradley | Director | 259 Morthen Road Wickersley S66 1DY Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 95762420001 | |||||
| CUNNINGHAM, Susan Dawn | Director | Morthen Road Wickersley S66 1DY Rotherham 259 South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 138688520001 | |||||
| DEVENPORT, Julie | Director | 8 Pessall Lane Edingale B79 9JN Tamworth Staffordshire | British | 106824970001 | ||||||
| DUKE, Trudy | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 140740470001 | |||||
| DYSON, Neil | Director | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | England | British | 169560320001 | |||||
| FOXALL, Kerris | Director | 118 Penkhull New Road Penkhull ST4 5DG Stoke On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 81363200001 | |||||
| KING, Richard | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 165897680001 | |||||
| LIGHTON, Amanda | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 198772920001 | |||||
| MELLA-RUA, Christine Alison | Director | Old Chapel House Rowthorne Lane Glapwell S44 5QF Chesterfield Derbyshire | England | British | 107869550002 | |||||
| PANCOTT, David | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 245049550001 | |||||
| PATUREL, Benoit Julien Mathieu | Director | 7 Upper Wimpole Street W1G 6LQ London | England | French | 64550070001 | |||||
| QUARRINGTON, Julie | Director | 15 Tattersett Road Syderstone PE31 8SA Kings Lynn Norfolk | England | British | 66890990002 | |||||
| ROBSON, James | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 245049510001 | |||||
| ROWE-BEWICK, David | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | United Kingdom | British | 185125250001 | |||||
| SANDS, Angela | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 245049560001 | |||||
| STORR, Christine | Director | 24 Ashdell Road Broomhill S10 3DA Sheffield South Yorkshire | British | 81360770001 | ||||||
| STURROCK, David | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 245049540001 | |||||
| TAYLOR, Karen Vivien | Director | The Farmhouse Aldham Mill Barnsley Road S73 8EG Wombwell South Yorkshire | United Kingdom | British | 120510920001 | |||||
| TAYLOR, Karen Vivien | Director | The Farmhouse Aldham Mill Barnsley Road S73 8EG Wombwell South Yorkshire | United Kingdom | British | 120510920001 | |||||
| THOMAS, Lisa Jayne | Director | Park Lane Burton Waters LN1 2YZ Lincoln 115 | Scotland | British | 138694230001 | |||||
| WATERS, Lynne | Director | Ferham House Kimberworth Road Masbrough S61 1AJ Rotherham South Yorkshire | England | British | 260483920001 | |||||
| WATSON, Serena | Director | Greenwood Avenue Upton WF9 1NS Pontefract 10 West Yorkshire United Kingdom | British | 138688530001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FAIRBURN MEWS HEALTH CARE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exemplar Holdings Ltd | 06 abr 2016 | 17 Europa View S9 1XH Sheffield Exemplar Health Care Support Centre England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0