L3 TECHNOLOGY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | L3 TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04242731 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de L3 TECHNOLOGY LIMITED?
- Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra L3 TECHNOLOGY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5 Technology Park Colindeep Lane NW9 6BX London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de L3 TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MEAUJO (534) LIMITED | 28 jun 2001 | 28 jun 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de L3 TECHNOLOGY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para L3 TECHNOLOGY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 62 Bradbourne Road Sevenoaks Kent TN13 3QA a 5 Technology Park Colindeep Lane London NW9 6BX el 01 ago 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Emms Gilmore Liberson Lancaster House 67 Newhall Street Birmingham B3 1NQ England a 2 Royal College Street London NW1 0NH | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Notification de Jupiter Diagnostics Holding Company Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 dic 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 jun 2017 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Cancelación de acciones. Estado de capital el 01 dic 2016
| 5 páginas | SH06 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 01 dic 2016
| 5 páginas | SH01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 11 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Dr Christopher Mark Ball como director el 01 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2016 au 31 mar 2017 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Mcpartland como director el 01 dic 2016 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anglo Scientific Ltd como secretario el 01 dic 2016 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Elms Courtyard, Bromsberrow Ledbury Herefordshire HR8 1RZ a 62 Bradbourne Road Sevenoaks Kent TN13 3QA el 28 dic 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Compra de acciones propias. | 3 páginas | SH03 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 042427310002 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Segunda presentación de la declaración anual hasta 28 jun 2016 | 24 páginas | RP04AR01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 27 páginas | MA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de L3 TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALL, Christopher Mark, Dr | Director | Technology Park Colindeep Lane NW9 6BX London 5 England | England | British | 147184320001 | |||||||||
| ROLFE, James Leonard | Director | Technology Park Colindeep Lane NW9 6BX London 5 England | United Kingdom | British | 161540960001 | |||||||||
| COOKSON, Owen Thomas Burrows | Secretario | The Old Vicarage 5 Station Road Little Houghton NN7 1AJ Northampton Northamptonshire | British | 29814620001 | ||||||||||
| DUNDONALD, Iain Alexander Douglas Blair, Earl Of | Secretario | Lochnell Castle PA37 1QT Ledaig Argyll | British | 80555460001 | ||||||||||
| ROLFE, James Leonard | Secretario | Parkview Church Lane GL54 5DQ Toddington Gloucestershire | British | 76259760001 | ||||||||||
| ANGLO SCIENTIFIC LTD | Secretario corporativo | The Elms Courtyard Bromsberrow HR8 1RZ Ledbury Herefordshire |
| 98915170003 | ||||||||||
| PHILSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | St Philips House St Philips Place B3 2PP Birmingham West Midlands | 900006520001 | |||||||||||
| BESTWICK, Timothy David, Dr | Director | The Old Mill House Mill Lane, Adderbury OX17 3LW Banbury Oxfordshire | England | British | 67325990002 | |||||||||
| BUCK, Dawson | Director | Dunsfold Ryse GU8 4YA Chiddingfold Surrey | United Kingdom | British | 109408200001 | |||||||||
| DUNDONALD, Iain Alexander Douglas Blair, Earl Of | Director | Lochnell Castle PA37 1QT Ledaig Argyll | United Kingdom | British | 80555460001 | |||||||||
| GEORGE, David Richard | Director | Bakers Farm Blackmore End CM7 4DJ Braintree Essex | England | British | 18166290002 | |||||||||
| HARDCASTLE, John Kenneth Willis | Director | Ridgecote 26 Dawstone Road Heswall CH60 0BU Wirral Merseyside | England | British | 122293450001 | |||||||||
| HYDE-THOMSON, Henry Charles Anthony | Director | The Elms Courtyard, Bromsberrow Ledbury HR8 1RZ Herefordshire | United Kingdom | British | 78884600001 | |||||||||
| JONES, Gareth Royston | Director | Ty Alban 11 Churchfields Bowdon WA14 3PL Altrincham Cheshire | England | British | 83523200002 | |||||||||
| MCPARTLAND, Peter | Director | Bromsberrow HR8 1RZ Ledbury The Elms Courtyard United Kingdom | England | British | 155226180001 | |||||||||
| NICHOLLS, Anthony Charles, Doctor | Director | The Elms Courtyard, Bromsberrow Ledbury HR8 1RZ Herefordshire | United Kingdom | British | 101404360001 | |||||||||
| ROLFE, James Leonard | Director | Church Lane GL54 5DO Toddington Park View Glos | England | British | 76259760001 | |||||||||
| ROLFE, James Leonard | Director | Parkview Church Lane GL54 5DQ Toddington Gloucestershire | England | British | 76259760001 | |||||||||
| THELWALL-JONES, Simon | Director | Mulsford Lane Sarn SY14 7LW Malpas The Hayloft Cheshire | England | British | 131757370001 | |||||||||
| TOWNS ANDREWS, Elizabeth, Dr | Director | 24 Pool Lane WA13 9BJ Lymm Cheshire | United Kingdom | British | 113884920001 | |||||||||
| VERNON, Paul Morgan | Director | 4 Houghton Close CH2 3TB Chester Cheshire | British | 93190040001 | ||||||||||
| WHITCOMBE, David Mark | Director | The Elms Courtyard, Bromsberrow Ledbury HR8 1RZ Herefordshire | United Kingdom | British | 154000990001 | |||||||||
| MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED | Director designado corporativo | St Philips House St Philips Place B3 2PP Birmingham West Midlands | 900006510001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de L3 TECHNOLOGY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Diagnostics Holding Company Ltd | 01 dic 2016 | NW11 8ED Golders Green 10-14 Accommodation Road London United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene L3 TECHNOLOGY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 21 feb 2014 Entregado el 27 feb 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción By way of fixed legal mortgage over all real property.. By way of fixed equitable charge of all the borrower's estates, rights or interests in any freehold or leasehold property belonging to the borrower now or at any time in the future, together with all buildings and fixtures which are at any time on or attached to such proeprty and the proceeds of any sale of them.. By way of fixed charge over all present and future intellectual property.. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 15 feb 2011 Entregado el 25 feb 2011 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the holders of an issue of £300,000 secured convertible loan notes under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over assets present and future, including uncalled capital, receivables, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0