CARP (H) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARP (H) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04246719
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARP (H) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CARP (H) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    One Edison Rise, New Ollerton
    Newark
    NG22 9DP Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARP (H) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CENTER PARCS (UK) HOLDINGS LIMITED10 oct 200110 oct 2001
    CARP (UK) 2A LIMITED24 jul 200124 jul 2001
    ALNERY NO. 2168 LIMITED05 jul 200105 jul 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARP (H) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta23 abr 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARP (H) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Cancelación total de la carga 5

    5 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 13 abr 2016

    LRESSP

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 23 mar 2016

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 22/03/2016
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 05 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 jul 2015

    Estado de capital el 17 jul 2015

    • Capital: GBP 8,199,332
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 23 abr 2015

    6 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Paul Inglett el 01 sept 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 05 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 jul 2014

    Estado de capital el 28 jul 2014

    • Capital: GBP 8,199,332
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 abr 2014

    6 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 abr 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jul 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 29 jul 2013

    SH01

    Cambio de datos del director Martin Peter Dalby el 17 abr 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Martin Peter Dalby el 17 abr 2013

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 abr 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 05 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de CARP (H) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SINGH-DEHAL, Rajbinder
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secretario
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Other138962680001
    DALBY, Martin Peter
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish83381250004
    INGLETT, Paul
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Director
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81617110003
    BRADSHAW, Andrew Philip
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Secretario
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    British114356940001
    BRIGGS, Hugh Alexander
    6 Austral Street
    Kennington
    SE11 4SJ London
    Secretario
    6 Austral Street
    Kennington
    SE11 4SJ London
    British79558350002
    CUMMINS, Diarmuid
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    Secretario
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    British78791890003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Secretario
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Secretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    Secretario
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    British138694570001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Secretario
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secretario designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALLEN, Matthew Charles
    75 Park Road
    W4 3EY London
    Director
    75 Park Road
    W4 3EY London
    EnglandBritish37599910001
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Director
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Other94259330004
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Director
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    DALBY, Martin Peter
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    Director
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    British83381250001
    DALBY, Martin Peter
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    Director
    12 Easthorpe
    NG25 0HY Southwell
    Nottinghamshire
    British83381250001
    DALE, Manjit
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    Director
    84 Highgate
    West Hill
    N6 6LU London
    EnglandBritish69966070002
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Director
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritish76313640003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Director
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    HAWKES, Edward Jonathan Cameron
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    Director
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    United KingdomBritish93239900002
    JONAS, Marc Nicholas
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Director
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    EnglandBritish55841850004
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Director
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Director
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Director
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritish87606860002
    PURSLOW, Christian Mark Cecil
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    Director
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    United KingdomBritish83244210001
    ROBERTSON, Stephen James
    1 Hereford House
    13 Lauriston Road
    SW19 4JJ London
    Director
    1 Hereford House
    13 Lauriston Road
    SW19 4JJ London
    British78505200001
    ROBINSON, Anthony Martin
    5 Gorse Corner
    Townsend Drive
    AL3 5SH St Albans
    Hertfordshire
    Director
    5 Gorse Corner
    Townsend Drive
    AL3 5SH St Albans
    Hertfordshire
    British55873860003
    SEAWARD, Julian Lloyd
    128 Priory Lane
    SW15 5JP London
    Director
    128 Priory Lane
    SW15 5JP London
    British77259160001
    SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    Director
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    EnglandBritish54889660001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Director
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United States107030970001
    WILSON, Christopher
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    Director
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    British103272700001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    ¿Tiene CARP (H) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Borrower deed of charge
    Creado el 28 feb 2012
    Entregado el 20 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Borrower Security Trustee)
    Transacciones
    • 20 mar 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 06 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Securitisation floating charge debenture
    Creado el 19 jun 2007
    Entregado el 04 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited
    Transacciones
    • 04 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 jun 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 19 jun 2007
    Entregado el 04 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited
    Transacciones
    • 04 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 jun 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Intercreditor deed
    Creado el 19 jun 2007
    Entregado el 05 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited
    Transacciones
    • 05 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 14 jun 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A security over shares deed
    Creado el 19 jun 2007
    Entregado el 04 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the tax covenant benficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The charged portfolio meaning in relation to the company its charged shares and related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transacciones
    • 04 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 05 nov 2002
    Entregado el 15 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed equitable charge all securities belonging to the company and by way of floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Lyonnais (Acting as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries and Includes Anysuccessor Appointed by the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 15 nov 2002Registro de un cargo (395)
    • 20 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CARP (H) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    13 abr 2016Inicio de la liquidación
    29 mar 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0