THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED

THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04258762
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    • (6523) /

    ¿Dónde se encuentra THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THINC DESTINI TRAIL COLLECTIONS LIMITED18 jul 200618 jul 2006
    DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED29 abr 200529 abr 2005
    DESTINI FINANCIAL SERVICES GROUP PLC27 jun 200227 jun 2002
    GREENOAK MARKETING GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY30 ago 200130 ago 2001
    INDIGOHONEY PUBLIC LIMITED COMPANY25 jul 200125 jul 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 29 dic 2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Share premium account and other reserve be reduced to zero 22/12/2011
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    21 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Cese del nombramiento de Alasdair Mackay como director

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 23 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Jeremy Peter Small el 23 abr 2010

    1 páginasCH03

    Nombramiento de Alasdair Mackay como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    14 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    16 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Secretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    BritishCompany Director67168210001
    ANDERSON, Philip John
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    Director
    1 Warmans Close
    Bawburgh
    NR9 3JB Norwich
    Norfolk
    UkBritishFinancial Director79136250001
    COLLETT, David
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    Secretario
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    BritishDirector101014620001
    O'CONOR, Patrick Francis
    51 Downs Park West
    BS6 7QL Bristol
    Somerset
    Secretario
    51 Downs Park West
    BS6 7QL Bristol
    Somerset
    British50372870001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Secretario
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    BritishDirector130449650001
    SMITH, Nicholas
    Corner Cottage
    Crab Mill Lane, Lea
    SN16 9PF Malmesbury
    Wiltshire
    Secretario
    Corner Cottage
    Crab Mill Lane, Lea
    SN16 9PF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishSolicitor83415330001
    CHANCERY NOMINEE SERVICES LIMITED
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario corporativo
    Chancery Pavilion
    Boycott Avenue Oldbrook
    MK6 2TA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    98153140001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRISTOL, Teresa Louise
    35 Sherbourne Street
    St George
    BS5 8EQ Bristol
    Director
    35 Sherbourne Street
    St George
    BS5 8EQ Bristol
    BritishManager83991510001
    COLLETT, David
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    Director
    4 Silver Street
    GL8 8DH Tetbury
    Gloucestershire
    BritishDirector101014620001
    EVERILL, Jonathan Robert Edwin
    9 Brambles Close
    Ash
    GU12 6NY Aldershot
    Hampshire
    Director
    9 Brambles Close
    Ash
    GU12 6NY Aldershot
    Hampshire
    BritishIfa34156430003
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    Director
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    BritishFinancial Adviser105488120003
    GALVIN WRIGHT, Jonathon William
    9 Saint Helena Road
    BS6 7NR Bristol
    Director
    9 Saint Helena Road
    BS6 7NR Bristol
    BritishMarketing Director79499790001
    GRIFFITHS, Mark Roderick Winton
    18 Portland Square
    BS2 8SJ Bristol
    Avon
    Director
    18 Portland Square
    BS2 8SJ Bristol
    Avon
    BritishSolicitor61034080001
    LINDLEY, Richard Malcolm
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    Director
    2 Kensington Place
    Wellingborough Road
    MK46 4BG Olney
    Buckinghamshire
    UkBritishCompany Director98560430001
    LUMSDEN COOK, Anthony James
    Warren House
    Blockley
    GL56 9HL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Director
    Warren House
    Blockley
    GL56 9HL Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    BritishLloyds Underwriter78707170001
    MACKAY, Alasdair Iain
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritishNone146368090001
    PARSONS, Barry Gilbert
    Falcon Lodge
    New Road Greens Norton
    NN12 8BW Towcester
    Northamptonshire
    Director
    Falcon Lodge
    New Road Greens Norton
    NN12 8BW Towcester
    Northamptonshire
    BritishDirector91796850001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    Director
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Operating Officer130449650001
    SCOTT, Graham Leslie
    Millfield House
    Church Road
    SY3 9HQ Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    Millfield House
    Church Road
    SY3 9HQ Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishIndependent Financial Adviser78187980001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Director designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    ¿Tiene THINC TRAIL COLLECTIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 25 nov 2005
    Entregado el 10 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 10 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 nov 2005
    Entregado el 08 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential UK Services Limited
    Transacciones
    • 08 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creado el 04 jun 2003
    Entregado el 21 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Scottish equitable policy no: L0194075832 dl (barry gilbert parsons). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creado el 04 jun 2003
    Entregado el 21 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Scottish equitable policy no: L0192175832 dt (david john collett). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 abr 2003
    Entregado el 09 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 24 nov 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0