TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED

TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTRIBAL TECHNOLOGY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04269915
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Kings Orchard Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TRIBAL TECHNOLOGY SERVICES LIMITED14 oct 200214 oct 2002
    TRIBAL LEARNING LIMITED20 feb 200220 feb 2002
    IMCO (352001) LIMITED14 ago 200114 ago 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Estado de capital el 26 ene 2018

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 14 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 ago 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Pickett como director el 18 jul 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Derrick Breach como director el 18 jul 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Ian James Bowles como director el 01 mar 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Robert Charles Garner como director el 01 mar 2016

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 14 ago 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 ago 2015

    Estado de capital el 26 ago 2015

    • Capital: GBP 737,607
    SH01

    Nombramiento de Mr Robert Charles Garner como director el 01 jul 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Keith Martin Evans como director el 30 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 14 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 ago 2014

    Estado de capital el 29 ago 2014

    • Capital: GBP 737,607
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Stephen Derrick Breach el 05 jun 2014

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR United Kingdom a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ el 04 ago 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    16 páginasAA

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOWLES, Ian James
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Director
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    United KingdomBritish206100790001
    PICKETT, Mark Jeremy
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Director
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    EnglandBritish210493320001
    BIGGIN, Charles Arnold John
    7 Ranmoor Crescent
    S10 3GU Sheffield
    Secretario
    7 Ranmoor Crescent
    S10 3GU Sheffield
    British34909930001
    COLLINS, Richard Hawke
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Secretario
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    British53398040001
    DAVIS, Lorraine Anne
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Secretario
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    150940480001
    DAVIS, Lorraine Anne
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Secretario
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    150940300001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    British68807890004
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    Secretario
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British50767140001
    BIGGIN, Charles Arnold John
    7 Ranmoor Crescent
    S10 3GU Sheffield
    Director
    7 Ranmoor Crescent
    S10 3GU Sheffield
    EnglandBritish34909930001
    BREACH, Stephen Derrick
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Director
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritish174695940001
    CHAMBERS, James Robert
    The Old Vicarage
    Hackney Lane Barlow
    S18 7TR Dronfield
    Derbyshire
    Director
    The Old Vicarage
    Hackney Lane Barlow
    S18 7TR Dronfield
    Derbyshire
    EnglandBritish121875910001
    CLARK, Ross Mckenzie
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    Director
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    British72052540003
    EVANS, Keith Martin, Dr
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Director
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritish83582830002
    FRETWELL DOWNING, Francis Anthony, Dr
    15 School Green Lane
    S10 4GP Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    15 School Green Lane
    S10 4GP Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish24215150001
    GARNER, Robert Charles
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Director
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    United KingdomBritish53391420003
    LAWTON, Simon Marcus
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Director
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish68807890004
    MARTIN, Peter John
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Director
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritish176044430001
    MYCHALKIW, Petro
    26 Sandringham Close
    S41 8RQ Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    26 Sandringham Close
    S41 8RQ Chesterfield
    Derbyshire
    British39376470002
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish55231490005
    SAMPSON, Mark Justin
    33 Newfield Lane
    S17 3DB Dore
    South Yorkshire
    Director
    33 Newfield Lane
    S17 3DB Dore
    South Yorkshire
    British98223260001
    TYNE, Paul John
    Woodlands
    23 Barrs Lane
    GL11 6DT North Nibley
    Gloucestershire
    Director
    Woodlands
    23 Barrs Lane
    GL11 6DT North Nibley
    Gloucestershire
    British119096810001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Tribal Group Plc
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    06 abr 2016
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    Autoridad legalEnglish Law
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene TRIBAL TECHNOLOGY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 14 jun 2007
    Entregado el 21 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee and debenture made between certain subsidiaries of tribal group PLC and the governor and company of the bank of scotland
    Creado el 13 dic 2002
    Entregado el 24 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each group company to the security trustee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting as Security Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transacciones
    • 24 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creado el 17 oct 2002
    Entregado el 23 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 24 abr 2002
    Entregado el 30 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Each of the Financeparties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 30 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 08 feb 2002
    Entregado el 19 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0