RED FUNNEL FERRIES LIMITED

RED FUNNEL FERRIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRED FUNNEL FERRIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04281782
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GREENSOURCE LIMITED05 sept 200105 sept 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Notification de Falcon Acquisitions Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ene 2018

    2 páginasPSC02

    Cessation de Red Funnel Group (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ene 2018

    1 páginasPSC07

    Notification de Red Funnel Group (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ene 2018

    2 páginasPSC02

    Cessation de Red Funnel Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ene 2018

    1 páginasPSC07

    Cancelación total de la carga 042817820005

    1 páginasMR04

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 31 ene 2018

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Edward Arthur Wilson como director el 08 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Francis Campbell como director el 08 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Charles John Gore Hazelwood como director el 08 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jonathan Mark Moorhouse Green como director el 11 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Arthur Murray Carter como director el 11 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Mark Slawson como director el 11 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Wallace Inch como director el 12 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lee Richard Hudson como director el 12 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Shirley Ann Anderson como director el 13 sept 2017

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 042817820004

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 07 ago 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 042817820005, creada el 20 jul 2017

    17 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GEORGE, Kevin Alan
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish186130710001
    WINTER, Paul Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish132752850001
    HUME, Kate
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    Secretario
    Broadwalk House
    5 Appold Street
    EC2A 2HA London
    British78063700002
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Secretario
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British8125620001
    SHEARD, John Paul
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    Secretario
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    British61554710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDERSON, Shirley Ann
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish254667910001
    BLAND, Christopher Donald Jack
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    Director
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    United KingdomBritish8125610001
    BRADBURY, Kenton Edward
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish147513860001
    CAMPBELL, Michael Francis
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    CanadaCanadian235365510001
    CARTER, Arthur Murray
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish127391460001
    COOPER, James Nigel Shelley
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish265561970001
    DELLACHA, Maria Georgina
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish174489750001
    DOCHERTY, Thomas James
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    Director
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritish83269560002
    DOMINY, Jacqueline
    Woodlands 46 Telegraph Road
    West End
    SO30 3EX Southampton
    Hampshire
    Director
    Woodlands 46 Telegraph Road
    West End
    SO30 3EX Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish206004200001
    EDWARDS, Keith David William
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish114681720002
    FULFORD, James Simon Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish137465940001
    GLASS, Olive Helen
    55 Ashdale Park
    RG40 3QS Wokingham
    Berkshire
    Director
    55 Ashdale Park
    RG40 3QS Wokingham
    Berkshire
    British38249750003
    GORDON, Gavin James
    Flat 8 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7ER London
    Director
    Flat 8 The Design Works
    93-99 Goswell Road
    EC1V 7ER London
    British90600880001
    GREEN, Jonathan Mark Moorhouse
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish127407610001
    HAZELWOOD, Charles John Gore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish111535480002
    HELMORE, Max David Charles
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish174349030001
    HETHERINGTON, Colin Crawford
    Woodpeckers
    64 Baring Road
    PO31 8DJ Cowes
    Isle Of Wight
    Director
    Woodpeckers
    64 Baring Road
    PO31 8DJ Cowes
    Isle Of Wight
    British103607280004
    HUDSON, Lee Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish156861680001
    INCH, John Wallace
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish222917320001
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Director
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British8125620001
    NELSON, Stephen Keith James
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish91708030001
    RAYNER, William John
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish99969530001
    SCHUMACHER, Bernd
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandGerman169583030001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish107002130001
    SLAWSON, James Mark
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish191539160001
    WHYTE, Alistair Morrison
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    Director
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish8125600001
    WILSON, Edward Arthur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Director
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RED FUNNEL FERRIES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Red Funnel Group (Holdings) Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    31 ene 2018
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro05115188
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Falcon Acquisitions Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    31 ene 2018
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro06238324
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Red Funnel Group Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    06 abr 2016
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalEnglish Law
    Lugar de registroUk Company Register
    Número de registro03968658
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene RED FUNNEL FERRIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 20 jul 2017
    Entregado el 27 jul 2017
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    All land (except for restricted land) as listed in schedule 1 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon, intellectual property (except for any restricted ip), and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbc Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 27 jul 2017Registro de una carga (MR01)
    • 01 feb 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 08 jul 2016
    Entregado el 12 jul 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 12 jul 2016Registro de una carga (MR01)
    • 10 ago 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 25 oct 2007
    Entregado el 01 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 01 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 jul 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Red funnel deed of charge
    Creado el 21 dic 2001
    Entregado el 02 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings being k/a the red funnel ferry terminal car parks and car marshalling areas east cowes isle of wight t/nos IW49024, IW49023, IW49041, IW42695, IW29058 all f/h land and buildings at fountain quay west cowes t/no IW49025 f/h land and buldings at 10,12,14 and 16 bugle street southampton t/no HP596087 (for full details of all property charged see form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of New York (For Itself and on Behalf of the Other Red Funnel Secured Parties) (the "Security Trustee")
    Transacciones
    • 02 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 oct 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 oct 2001
    Entregado el 26 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present or future obligations of the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Company of New Yorkas Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transacciones
    • 26 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 ene 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0