RAVENSTOCK MSG LIMITED

RAVENSTOCK MSG LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRAVENSTOCK MSG LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04283040
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RAVENSTOCK MSG LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra RAVENSTOCK MSG LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Ravenstock House 28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAVENSTOCK MSG LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FREEPEAK LIMITED06 sept 200106 sept 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RAVENSTOCK MSG LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAVENSTOCK MSG LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 sept 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Christopher Miner como director el 16 jun 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Hezron Lopez como director el 16 jun 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Steven Dickinson como director el 15 mar 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Thompson como director el 13 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Timothy Boswell como director el 30 ago 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Bradley Soultz como director el 30 ago 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Van Welch como director el 30 ago 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kelly Williams como director el 30 ago 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 06 sept 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 042830400011

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 042830400013

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 042830400012

    1 páginasMR04

    Registro de la carga 042830400014, creada el 01 jul 2020

    68 páginasMR01

    Nombramiento de Kelly Williams como director el 29 ene 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Andrew Thompson como director el 29 ene 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Erik Olsson como director el 29 ene 2020

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de RAVENSTOCK MSG LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOSWELL, Timothy
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    United StatesAmericanDirector287361540001
    DICKINSON, Steven
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    EnglandBritishFinance Director294129760001
    LOPEZ, Hezron
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    United StatesAmericanChief Legal & Compliance Officer297208110001
    PARKES, Graeme Bryan
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    United StatesAmericanChief Information Officer243214530001
    SOULTZ, Bradley
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    United StatesAmericanDirector287361420001
    HALCHISHAK, Ronald
    The Stables
    Wynyard
    TS22 5QQ Billingham
    16
    Cleveland
    United Kingdom
    Secretario
    The Stables
    Wynyard
    TS22 5QQ Billingham
    16
    Cleveland
    United Kingdom
    AmericanSecretary137171890001
    MORGAN, Christopher David
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Secretario
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    191945810001
    ROBERTSON, James Stirling
    16510 Academia Drive
    CA 91436 Encino
    California
    Usa
    Secretario
    16510 Academia Drive
    CA 91436 Encino
    California
    Usa
    AmericanSenior Vice President69784390001
    VILLEGAS, Allan A
    2182 E Dudley Street
    CA 91104 Pasadena
    Usa
    Secretario
    2182 E Dudley Street
    CA 91104 Pasadena
    Usa
    British127472710001
    WILSON, Christopher
    1026 Fairview Drive
    FOREIGN La Canada
    California 91011
    United States
    Secretario
    1026 Fairview Drive
    FOREIGN La Canada
    California 91011
    United States
    AmericanGeneral Councel91823060001
    CREMORNE NOMINEES LIMITED
    32-38 Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Collins House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    32-38 Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Collins House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01227343
    3329890001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BUNGER, Steven
    West Trovita Place
    85226
    Chandler
    6134
    Arizona
    Usa
    Director
    West Trovita Place
    85226
    Chandler
    6134
    Arizona
    Usa
    UsaAmericanDirector112243740001
    DONOVAN, Michael
    54 West 82nd Street,
    Apt 5
    New York
    10024
    Usa
    Director
    54 West 82nd Street,
    Apt 5
    New York
    10024
    Usa
    AmericanDirector116940390001
    FUNK, Mark Edwin
    West Clarendon Avenue
    Phoenix
    60
    Arizona 85013
    United States
    Director
    West Clarendon Avenue
    Phoenix
    60
    Arizona 85013
    United States
    UsaAmericanExecutive Vp & Cfo137207360002
    HALCHISHAK, Ronald
    The Stables
    Wynyard
    TS22 5QQ Billingham
    16
    Cleveland
    United Kingdom
    Director
    The Stables
    Wynyard
    TS22 5QQ Billingham
    16
    Cleveland
    United Kingdom
    United KingdomAmericanDirector137171890001
    KEELEY, Deborah
    W Citation Lane
    85284 Tempe
    366
    Arizona
    Usa
    Director
    W Citation Lane
    85284 Tempe
    366
    Arizona
    Usa
    UsaAmericanDirector133387330002
    MELLIFONT, Kevin Michael
    148 Smoke Rise Road
    Bedminster New Jersey
    Nj 07921
    Usa
    Director
    148 Smoke Rise Road
    Bedminster New Jersey
    Nj 07921
    Usa
    AmericanChief Operating Officer70935090001
    MINER, Christopher
    E Laguna Azul
    85209 Meza
    10437
    Arizona
    United States
    Director
    E Laguna Azul
    85209 Meza
    10437
    Arizona
    United States
    United StatesAmericanDirector133585260001
    MORGAN, Christopher David
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    United KingdomBritishManaging Director84676900001
    MOSS, Neil
    103 Norbreck Close
    Great Sankey
    WA5 2SJ Warrington
    Cheshire
    Director
    103 Norbreck Close
    Great Sankey
    WA5 2SJ Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director82032760001
    OLSSON, Erik
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Uk
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Uk
    United StatesAmericanChief Executive177710530001
    ROBERTSON, James Stirling
    16510 Academia Drive
    CA 91436 Encino
    California
    Usa
    Director
    16510 Academia Drive
    CA 91436 Encino
    California
    Usa
    United StatesAmericanSenior Vice President69784390001
    SLINGERLAND, Robert
    4844 Petit Avenue
    Encino
    California 91436
    United States
    Director
    4844 Petit Avenue
    Encino
    California 91436
    United States
    AmericanChief Financial Officer91823200001
    SWANI, Sanjay
    33 East End Avenue, Apt 5-C
    New York
    New York 10028-7007
    Usa
    Director
    33 East End Avenue, Apt 5-C
    New York
    New York 10028-7007
    Usa
    AmericanChairman Of The Board116940480001
    THOMPSON, Andrew
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    EnglandBritishManaging Director266700000001
    TRACHTENBERG, Lawrence
    N Scottsdale Road
    85253 Scottsdale
    5646
    Arizona
    Uk
    Director
    N Scottsdale Road
    85253 Scottsdale
    5646
    Arizona
    Uk
    AmericanDirector133387210001
    VALENTA, Ronald Frank
    5200 Jessen Drive
    FOREIGN La Canada
    California Ca91011
    Usa
    Director
    5200 Jessen Drive
    FOREIGN La Canada
    California Ca91011
    Usa
    United StatesAmericanCompany President76325060001
    WAUGAMAN, Douglas
    25802 North Chisum Trail
    Scottsdale
    Arizona 85255
    United States
    Director
    25802 North Chisum Trail
    Scottsdale
    Arizona 85255
    United States
    AmericanPresident Ceo101550740001
    WELCH, Van
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    United StatesAmericanChief Financial Officer237406990001
    WILLIAMS, Kelly
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    Director
    28 Falcon Court
    Preston Farm Business Park
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    United StatesAmericanChief Executive266700350001
    CREMORNE NOMINEES NO 2 LIMITED
    Collins House 32-38 Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director corporativo
    Collins House 32-38 Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    51054270003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RAVENSTOCK MSG LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mobile Mini Uk Holdings Limited
    28 Falcon Court
    Preston Farm Industrial Estate
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    England
    06 abr 2016
    28 Falcon Court
    Preston Farm Industrial Estate
    TS18 3TX Stockton-On-Tees
    Ravenstock House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House, Cardiff
    Número de registro05749804
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene RAVENSTOCK MSG LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 jul 2020
    Entregado el 02 jul 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    Not applicable.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of America, N.A. (As Collateral Agent)
    Transacciones
    • 02 jul 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 22 mar 2019
    Entregado el 28 mar 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Not applicable.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag New York Branch (As Collateral Agent)
    Transacciones
    • 28 mar 2019Registro de una carga (MR01)
    • 02 jul 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 14 dic 2015
    Entregado el 31 dic 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag New York Branch (As Collateral Agent)
    Transacciones
    • 31 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    • 02 jul 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 10 dic 2014
    Entregado el 15 dic 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag New York Branch
    Transacciones
    • 15 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    • 02 jul 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 22 feb 2012
    Entregado el 01 mar 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag New York Branch
    Transacciones
    • 01 mar 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 02 jul 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 27 jun 2008
    Entregado el 10 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company, any UK credit party and a UK borrower to the chargee, an agent, any lender or any affiliate of any lender and any UK issuing lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    For details of properties charged, please refer to form 395, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag New York Branch (Collateral Agent)
    Transacciones
    • 10 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 08 mar 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 01 ago 2006
    Entregado el 21 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any subsidiary guarantor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Cit Group/ Business Credit, Inc. (Acting as UK Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 dic 2005
    Entregado el 06 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any UK borrower to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America N.A. as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries (The Uksecurity Trustee)
    Transacciones
    • 06 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 dic 2003
    Entregado el 05 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary by the UK borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, N.a; As Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries (The Uksecurity Trustee)
    Transacciones
    • 05 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of deposit
    Creado el 15 oct 2002
    Entregado el 23 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits now and in the future credited to account designation 23743344 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 09 ago 2002
    Entregado el 13 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from mobile storage (U.K.) limited and by the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the north side of north road bridgend industrial estate bridgend f/h t/no: WA842086. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 13 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental debenture
    Creado el 07 jun 2002
    Entregado el 13 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage north road, bridgend, mid glamorgan t/n WA84286, riverside avenue west, lawford, essex t/n EX432052, the leasehold property known as tees offshore base, dockside ride, southbank, middlesbrough, cleveland TS6 6UZ (for further details of property charged see part v of schedule to 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 13 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of deposit
    Creado el 28 ene 2002
    Entregado el 30 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All deposits credited to account designation 23723785 and any deposit or account of any other currency description or designation.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 30 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture between the company (formerly known as freepeak limited) and the bank of nova scotia for itself and as agent and security trustee for the UK lenders (as defined)
    Creado el 15 nov 2001
    Entregado el 20 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under the finance documents the guarantee or on any other account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of Nova Scotia
    Transacciones
    • 20 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 30 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0