BL HC (DSCLI) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBL HC (DSCLI) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04290601
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BL HC (DSCLI) LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BL HC (DSCLI) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BL HC (DSCLI) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ESPORTA (DSCLI) LIMITED16 mar 200716 mar 2007
    DUKE STREET CAPITAL LEISURE INVESTMENTS LIMITED27 nov 200127 nov 2001
    ROUGHBRIDGE LIMITED20 sept 200120 sept 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BL HC (DSCLI) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BL HC (DSCLI) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 12 sept 2023 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cessation de Bl Hc (Dsch) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov 2022

    1 páginasPSC07

    Notification de Bl Retail Warehousing Holding Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov 2022

    2 páginasPSC02

    Cese del nombramiento de Katherine Fyfe como director el 17 oct 2022

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 12 sept 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mrs Katherine Fyfe el 20 jul 2022

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mrs Katherine Fyfe como director el 20 jul 2022

    2 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    24 may 2023Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 24/05/2023 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    5 páginasAA

    Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 16 mar 2022

    1 páginasTM01

    Estado de capital el 21 abr 2022

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Charles John Middleton como director el 31 mar 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Gavin Bergin como director el 18 mar 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Nick Taunt como director el 18 mar 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sarah Morrell Barzycki como director el 18 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Paul Stuart Macey como director el 18 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Charles Mcnuff como director el 18 mar 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 12 sept 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de BL HC (DSCLI) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro8992198
    187856670001
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary251327820001
    TAUNT, Nick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant275050860001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Secretario
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    British58961410002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    162241780001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    SCOTT, Thomas James Buchan
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    Secretario
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    BritishChief Operating Officer92125880001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    WONG, Wai Chung
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    Secretario
    Flat 3 Rowsley Lodge
    72a Lady Margaret Road
    N19 5EL London
    BritishChartered Secretary123616460002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Director
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director Esporta Group58961410002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELKIN, Jeffrey Philip
    10a Sherriff Road
    NW6 2AU West Hampstead
    London
    Director
    10a Sherriff Road
    NW6 2AU West Hampstead
    London
    United KingdomBritishAccountant79906460001
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BRAINE, Anthony
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Director
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishExecutive Director, Esporta Gr96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector146698270001
    COOPER EVANS, Alexander Christopher
    Flat C
    5 Kensington Church Street
    W8 4LD London
    Director
    Flat C
    5 Kensington Church Street
    W8 4LD London
    BritishBanker80261980001
    COUPE, David John
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    Director
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    United KingdomBritishSolicitor125432970002
    CREED, Stuart John
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    Director
    Jade House The Avenue
    Claverton Down
    BA2 7AX Bath
    United KingdomBritishCompany Director3716600001
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer, Esporta Gr104269910002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    FYFE, Katherine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishAssistant Company Secretary293284010001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Director
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive Esporta Group69204500003
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Director
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    BritishDivisional Director, Esporta G100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    HUDSON, John Christopher Mozeen
    15 Neville Close
    RG21 3HG Basingstoke
    Hampshire
    Director
    15 Neville Close
    RG21 3HG Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant53713800001
    IRENS, Nicholas James
    Whitegates Farm
    Grants Lane
    RH8 0RQ Oxted
    Surrey
    Director
    Whitegates Farm
    Grants Lane
    RH8 0RQ Oxted
    Surrey
    BritishCompany Director65447080002
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Director designado
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Director
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishDirector135618280002
    LEBUS, Timothy Andrew
    70 Ellerby Street
    SW6 6EZ London
    Director
    70 Ellerby Street
    SW6 6EZ London
    BritishBanker6855830001
    MACEY, Paul Stuart
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Director
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant205652070001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BL HC (DSCLI) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    25 nov 2022
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland
    Número de registro06002154
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Bl Hc (Dsch) Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 abr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene BL HC (DSCLI) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating security document
    Creado el 18 jun 2009
    Entregado el 26 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 26 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Group debenture
    Creado el 08 feb 2006
    Entregado el 18 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transacciones
    • 18 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 ene 2004
    Entregado el 07 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Electra Partners Europe Limited as Noteholders' Agent and Noteholders' Security Trustee Andnoteholders Security Trust (The "Noteholders' Security Trustee")
    Transacciones
    • 07 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 ene 2004
    Entregado el 03 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 07 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 may 2002
    Entregado el 05 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 05 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 20 nov 2001
    Entregado el 29 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0