HOMEGONE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOMEGONE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04292566
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOMEGONE LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra HOMEGONE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Akenside House
    3 Akenside Hill
    NE1 3UF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOMEGONE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AKENSIDE QUAYS LIMITED13 feb 200213 feb 2002
    HOMEGONE LIMITED24 sept 200124 sept 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOMEGONE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HOMEGONE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOMEGONE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013

    4 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cancelación total de la carga 7

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    3 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    3 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 24 sept 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 oct 2013

    Estado de capital el 24 oct 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2012

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 sept 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 sept 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2010

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Catherine Anne Kerr Rafferty el 24 sept 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2009

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2008

    3 páginasAA

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2007

    4 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de HOMEGONE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCGHIE, Christopher Halliday
    Lochangarth Bruce Street
    Lochmaben
    DG11 1PD Lockerbie
    Dumfriesshire
    Secretario
    Lochangarth Bruce Street
    Lochmaben
    DG11 1PD Lockerbie
    Dumfriesshire
    BritishDirector1316350002
    BRITTON, Geoffrey
    Cartref House
    Front Street Burnopfield
    NE16 6PT Newcastle Upon Tyne
    Director
    Cartref House
    Front Street Burnopfield
    NE16 6PT Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishChartered Surveyor32490000001
    CUTTS, Ashley
    Hillcrest
    Raikes Road
    FY5 5LS Thornton-Cleveleys
    Lancashire
    Director
    Hillcrest
    Raikes Road
    FY5 5LS Thornton-Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritishSurveyor7599670002
    MCGHIE, Christopher Halliday
    Lochangarth Bruce Street
    Lochmaben
    DG11 1PD Lockerbie
    Dumfriesshire
    Director
    Lochangarth Bruce Street
    Lochmaben
    DG11 1PD Lockerbie
    Dumfriesshire
    ScotlandBritishDirector1316350002
    RAFFERTY, Catherine Anne Kerr
    Torthorwald
    DG1 3QE Dumfries
    Roucanhill
    Director
    Torthorwald
    DG1 3QE Dumfries
    Roucanhill
    United KingdomBritishSolicitor26638760001
    CUTTS, Ashley
    14 Kings Walk
    Cleveleys
    FY5 1HZ Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Secretario
    14 Kings Walk
    Cleveleys
    FY5 1HZ Thornton Cleveleys
    Lancashire
    BritishChartered Surveyor7599670001
    HARRISON, John
    8 Adeline Gardens
    Gosforth
    NE3 4JQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    8 Adeline Gardens
    Gosforth
    NE3 4JQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British72765810001
    NEAL, Richard Jonathan
    Fenholme House Cade Hill Road
    NE43 7PB Stocksfield
    Northumberland
    Secretario
    Fenholme House Cade Hill Road
    NE43 7PB Stocksfield
    Northumberland
    British40736050002
    ROSS, Kenneth
    140 Highfield Road
    NE34 6JL South Shields
    Tyne & Wear
    Secretario
    140 Highfield Road
    NE34 6JL South Shields
    Tyne & Wear
    British46212020001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Secretario designado corporativo
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    LITTLE, Barry Joseph
    Wellbeck
    Green Lane Crosby On Eden
    CA6 4QN Carlisle
    Cumbria
    Director
    Wellbeck
    Green Lane Crosby On Eden
    CA6 4QN Carlisle
    Cumbria
    EnglandBritishCompany Director112071030001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Director designado corporativo
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    ¿Tiene HOMEGONE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge of deposit
    Creado el 24 jul 2007
    Entregado el 04 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of £90,000 credited to account designation number 10387194 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 30 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 03 feb 2004
    Entregado el 24 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £100,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The land and buildings on south side of bonners field, bonners field sunderland t/n TY65352 and bonners field public house and malting restaurant bonners field sunderland t/n TY174674 floating charge the entire assets and undertaking all the right title and interest to and in all plant and machinery all present and future goodwill and uncalled capital all present and future right title and interest in the securities all loan capital all intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Border Construction Limited
    Transacciones
    • 24 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 03 sept 2002
    Entregado el 06 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Freehold property being barbican house (formerly bonnersfield public house and malting restaurant) bonnersfield sunderland together with land and buildings on the south side t/n's TY65352 and TY174674. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 23 ago 2002
    Entregado el 28 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 27 nov 2001
    Entregado el 14 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Akenside Wharf Limited
    Transacciones
    • 14 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 abr 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 29 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 27 nov 2001
    Entregado el 17 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £900,000 principal and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Border Construction Limited
    Transacciones
    • 17 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 29 nov 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0