BETT (CALVER ROAD) LIMITED

BETT (CALVER ROAD) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBETT (CALVER ROAD) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04293393
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    • (7011) /

    ¿Dónde se encuentra BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Ashley House
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    READCO 309 LIMITED25 sept 200125 sept 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 16 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 sept 2010

    Estado de capital el 30 sept 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nombramiento de Michael Milligan como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    13 páginasAA

    Nombramiento de Paul Curran como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Gaffney como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Neil Fitzsimmons como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director David Gaffney el 29 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Dominic Lavelle como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robin Johnson como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Joanne Elizabeth Massey como secretario

    2 páginasAP03

    legacy

    3 páginasMG02

    Cambio de datos del secretario Robin Simon Johnson el 24 nov 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director David Gaffney el 13 nov 2009

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Dominic Joseph Lavelle como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 16 sept 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Comptes annuels modifiés établis au 31 dic 2007

    14 páginasAAMD

    Resoluciones

    Resolutions
    33 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Director's authorisation 01/09/2009
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de BETT (CALVER ROAD) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808340001
    CURRAN, Paul
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    Director
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish110978610002
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050002
    MILLIGAN, Michael
    Lauriston Place
    EH3 9EN Edinburgh
    15
    United Kingdom
    Director
    Lauriston Place
    EH3 9EN Edinburgh
    15
    United Kingdom
    ScotlandBritish153845120001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JACKSON, Guy Collingwood
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    British54131050002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    BEAZER, Anthony Hadyn
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    Director
    172b West Hill
    Putney
    SW15 3SL London
    United KingdomBritish91412650001
    BOND, Julian
    Broomfield House
    32 Hullen Edge Road
    HX5 0QY Elland
    Yorkshire
    Director
    Broomfield House
    32 Hullen Edge Road
    HX5 0QY Elland
    Yorkshire
    United KingdomBritish44995320003
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Director
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    JACKSON, Guy Collingwood
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Suncroft 38 Wynmore Avenue
    Bramhope
    LS16 9DE Leeds
    West Yorkshire
    British54131050002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    ROBINSON, David
    118 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Lothian
    Director
    118 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Lothian
    ScotlandUnited Kingdom50541770001
    TOWNSEND, Ian Trye
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    Director
    20 Viewfield Road
    DD11 2BU Arbroath
    Angus
    United KingdomBritish320150001

    ¿Tiene BETT (CALVER ROAD) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 09 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 09 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 23 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed legal charge
    Creado el 11 feb 2005
    Entregado el 03 mar 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £150,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    First fixed charge over the interest bearing account and any amount which may exist in the account from time to time.
    Personas con derecho
    • I.M. Properties Finance Limited
    Transacciones
    • 03 mar 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 21 may 2003
    Entregado el 24 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 20 may 2003
    Entregado el 28 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land to the south of calver road,winwick quay, warrington t/n CH478322. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0