BADMINTON HEALTHCARE LTD

BADMINTON HEALTHCARE LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBADMINTON HEALTHCARE LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04293809
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BADMINTON HEALTHCARE LTD?

    • (8514) /

    ¿Dónde se encuentra BADMINTON HEALTHCARE LTD?

    Dirección de la sede social
    Connaught House The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BADMINTON HEALTHCARE LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BADMINTON HEALTHCARE LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Angela Culhane como director el 25 jun 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    17 páginasAA

    Nombramiento de Jonathan David Calow como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Care Uk Services Limited como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 19 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 sept 2011

    Estado de capital el 06 sept 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    17 páginasAA

    Nombramiento de Paul John Watson como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 19 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Paul Justin Humphreys el 01 ago 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Care Uk Services Limited el 01 ago 2010

    2 páginasCH04

    Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 10 ago 2010

    2 páginasCH01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum de Asociación

    RES01

    legacy

    28 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    18 páginasAA

    Nombramiento de Deborah Jane Marriott-Boam como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Geoffrey Benn como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Roy Hastings como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Douglas Umbers como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Angela Hector Culhane como director

    2 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de BADMINTON HEALTHCARE LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CALOW, Jonathan David
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Secretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    165428740001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish151689670001
    PARISH, Michael Robert
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    EnglandBritish78828750003
    WATSON, Paul John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish82460360003
    HELLEY, Theresa
    The Bungalow
    Oat Hedges Farm
    BS27 3RU Cheddar
    Somerset
    Secretario
    The Bungalow
    Oat Hedges Farm
    BS27 3RU Cheddar
    Somerset
    British78190350001
    HODGKINS, Leigh
    8 Evergreen
    Charter House
    BS40 7XS Blagdon
    Somerset
    Secretario
    8 Evergreen
    Charter House
    BS40 7XS Blagdon
    Somerset
    British117712190001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    STADDEN, Hilary Anne
    16 Greenleaze Close
    Downend
    BS16 6LW Bristol
    Secretario
    16 Greenleaze Close
    Downend
    BS16 6LW Bristol
    British80075380001
    CARE UK SERVICES LIMITED
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2482660
    125332040002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Director
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Director
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    CULHANE, Angela
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    EnglandBritish68602910001
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Director
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    HODGKINS, Maureen
    Evergreen
    Charterhouse On Mendip
    BS40 7SX Blagdon
    Somerset
    Director
    Evergreen
    Charterhouse On Mendip
    BS40 7SX Blagdon
    Somerset
    British78191690005
    HODGKINS, Philip Steven
    Evergreen
    Charterhouse On Mendip
    BS40 7SX Blagdon
    Somerset
    Director
    Evergreen
    Charterhouse On Mendip
    BS40 7SX Blagdon
    Somerset
    British78191730003
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Director
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Director
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene BADMINTON HEALTHCARE LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 jul 2010
    Entregado el 26 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transacciones
    • 26 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 10 dic 2009
    Entregado el 23 dic 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 28 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 mar 2009
    Entregado el 13 mar 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 mar 2009Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 26 mar 2004
    Entregado el 02 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 02 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0