BADMINTON HEALTHCARE LTD
Visión general
| Nombre de la empresa | BADMINTON HEALTHCARE LTD |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04293809 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BADMINTON HEALTHCARE LTD?
- (8514) /
¿Dónde se encuentra BADMINTON HEALTHCARE LTD?
| Dirección de la sede social | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BADMINTON HEALTHCARE LTD?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BADMINTON HEALTHCARE LTD?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Culhane como director el 25 jun 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Jonathan David Calow como secretario el 08 dic 2011 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Care Uk Services Limited como secretario el 08 dic 2011 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Paul John Watson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 19 ago 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Paul Justin Humphreys el 01 ago 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Care Uk Services Limited el 01 ago 2010 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 10 ago 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 28 páginas | MG01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Deborah Jane Marriott-Boam como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Benn como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roy Hastings como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Douglas Umbers como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Angela Hector Culhane como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BADMINTON HEALTHCARE LTD?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALOW, Jonathan David | Secretario | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | 165428740001 | |||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||||||
| MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 151689670001 | |||||||||
| PARISH, Michael Robert | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | England | British | 78828750003 | |||||||||
| WATSON, Paul John | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 82460360003 | |||||||||
| HELLEY, Theresa | Secretario | The Bungalow Oat Hedges Farm BS27 3RU Cheddar Somerset | British | 78190350001 | ||||||||||
| HODGKINS, Leigh | Secretario | 8 Evergreen Charter House BS40 7XS Blagdon Somerset | British | 117712190001 | ||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Secretario | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | 33223550003 | ||||||||||
| STADDEN, Hilary Anne | Secretario | 16 Greenleaze Close Downend BS16 6LW Bristol | British | 80075380001 | ||||||||||
| CARE UK SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125332040002 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BENN, Geoffrey Richard | Director | 15 Mimosa Close CM1 6NW Chelmsford Essex | England | British | 73786580001 | |||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Director | Fairview 17a Queens Road WA15 9HF Hale Cheshire | United Kingdom | British | 14044530003 | |||||||||
| CULHANE, Angela | Director | The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | England | British | 68602910001 | |||||||||
| HASTINGS, Roy | Director | Wallis Road RG21 3DN Basingstoke 20 Hampshire | United Kingdom | British | 130098430001 | |||||||||
| HODGKINS, Maureen | Director | Evergreen Charterhouse On Mendip BS40 7SX Blagdon Somerset | British | 78191690005 | ||||||||||
| HODGKINS, Philip Steven | Director | Evergreen Charterhouse On Mendip BS40 7SX Blagdon Somerset | British | 78191730003 | ||||||||||
| UMBERS, Douglas | Director | SO53 | United Kingdom | British | 90541690001 | |||||||||
| VOCKINS, Anthony Frederick | Director | 4 Main Street Croxton Kerrial NG32 1QF Grantham The Old Post Office Lincolnshire | England | British | 130512090002 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Tiene BADMINTON HEALTHCARE LTD alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 21 jul 2010 Entregado el 26 jul 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 10 dic 2009 Entregado el 23 dic 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 mar 2009 Entregado el 13 mar 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 26 mar 2004 Entregado el 02 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0