ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04297040 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Victory Point Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Surrey England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AMBRIEL LIMITED | 28 ene 2002 | 28 ene 2002 |
| MBDA MISSILE SYSTEMS LIMITED | 06 nov 2001 | 06 nov 2001 |
| MONEYPATH LIMITED | 02 oct 2001 | 02 oct 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 06 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Gavin Scott como director el 31 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2024 | 9 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mr Mark Nicholson el 27 jun 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Adam Daniel White como director el 09 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023 | 4 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Joseph Michael Reed como director el 30 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Michael Ormond como director el 01 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Michael Deal como director el 30 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Kristina Anderson como director el 04 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Gordon Rankin Pitman como director el 03 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Louise Sara Wallwork como director el 03 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Philippa Kramer como director el 02 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Andrew Edward Martin como director el 03 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Andrew James Gallagher como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Robert Mark Stewart como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Arthur Mark Ruston Smith el 04 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Philippa Kramer el 04 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Ms Tina Louise Bailey el 04 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Robert Mark Stewart el 04 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Richard Bestwick el 04 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Dr Martin Alexander Brixner el 04 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Mark Nicholson el 04 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Louise Sara Wallwork el 04 dic 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMASTERS, Georgina Anne Bonville Were | Secretario | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | 303947850001 | |||||||
| ANDERSON, Kristina | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | England | British | 321754560001 | |||||
| BAILEY, Tina Louise | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | England | British | 262933470002 | |||||
| BESTWICK, Richard | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | United Kingdom | British | 224969440001 | |||||
| BRIXNER, Martin Alexander, Dr | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | Germany | French,German | 257425210001 | |||||
| DEAN, Andrew George | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | England | British | 149739040001 | |||||
| GREEN, David Alexander | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | United Kingdom | British | 170339810004 | |||||
| MARTIN, Andrew Edward | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | France | British | 317833330001 | |||||
| MCPHEE, Duncan Stewart | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | United Kingdom | British | 107666590001 | |||||
| NICHOLSON, Mark | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | England | British | 307460270002 | |||||
| ORMOND, Michael | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | England | British | 323024800001 | |||||
| PITMAN, Gordon Rankin | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | England | British | 321753630001 | |||||
| SMITH, Arthur Mark Ruston | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | United Kingdom | British | 253681190002 | |||||
| SMITH, Darren Mark | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | United Kingdom | British | 294819550001 | |||||
| WHITE, Adam Daniel | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | England | British | 328026720001 | |||||
| WILSON, Alan John | Director | Lyon Way, Frimley GU16 7EX Camberley Victory Point Surrey England | United Kingdom | British | 291380680001 | |||||
| BAYER, George William | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | Other | 138537490002 | ||||||
| BEER, Hayley Alice | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems-Company Secretariat Hants. United Kingdom | 165728910001 | |||||||
| CLIFTON, Hayley Alice | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | 241778370001 | |||||||
| CLIFTON, Hayley Alice | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | 206395460001 | |||||||
| COOK, Julie Anne | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | 287016730001 | |||||||
| COOK, Julie Anne | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | 262095990001 | |||||||
| EFFANGA, Betse Geraldine | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | 253532110001 | |||||||
| GOODGE, Linda Susan | Secretario | Upwood Road Ramsey Heights PE26 2RY Huntingdon Waterside Lodge Cambridgeshire United Kingdom | British | 44156900004 | ||||||
| HOLMES, David | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | 216376020001 | |||||||
| MILLER, Marian Alison | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | 186306990001 | |||||||
| RICHARDS, Louisa | Secretario | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | 275070450001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BAKER, Richard Ian | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | England | British | 163934750002 | |||||
| BLAKEMORE, Charles Anthony | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | United Kingdom | British | 126468520001 | |||||
| BLUNT, Nigel Richard | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | England | British | 126463130001 | |||||
| BRENNAN, Thomas Andrew | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | British | 126468590001 | ||||||
| BYFIELD, Michael John | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | England | British | 196293110003 | |||||
| COLE, David | Director | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | United Kingdom | British | 37453200001 | |||||
| DEAL, Christopher Michael | Director | Six Hills Way SG1 2DA Stevenage Mbda Uk Ltd Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 227886870001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALVIS PENSION SCHEME TRUSTEES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bae Systems Plc | 25 mar 2019 | Carlton Gardens SW1Y 5AD London 6 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Bae Systems Global Combat Systems Limited | 06 abr 2016 | PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough Warwick House Hampshire United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0