AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED

AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04301069
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Aon Centre The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LORICA CONSULTING LIMITED15 jul 200515 jul 2005
    HEALTH FOR INDUSTRY LIMITED25 ene 200225 ene 2002
    CONTACTBASE LIMITED09 oct 200109 oct 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 26 sept 2016

    LRESSP

    Cese del nombramiento de David Charles Battle como director el 21 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christine Marie Williams como director el 19 sept 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Alistair Patrick Boyd como director el 19 sept 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Paul Arthur Hogwood como director el 23 ago 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Tobin Mathew Murphy-Coles como director el 01 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Neville Herbert como director el 19 jul 2016

    1 páginasTM01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Dec nom cap 20/11/2015
    RES13

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 30 nov 2015

    • Capital: GBP 0.01
    4 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 09 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 oct 2015

    Estado de capital el 21 oct 2015

    • Capital: GBP 250,100
    SH01

    Cambio de datos del director Mr David Charles Battle el 13 jul 2015

    2 páginasCH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 8 Devonshire Square London EC2M 4PL England a 10 Devonshire Square London EC2M 4YP

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 8 Devonshire Square London EC2M 4PL

    1 páginasAD03

    Cambio de datos del secretario Cosec 2000 Limited el 13 jul 2015

    1 páginasCH04

    Cambio de datos del director Christine Marie Williams el 13 jul 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director James Neville Herbert el 13 jul 2015

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COSEC 2000 LIMITED
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre, The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre, The Leadenhall Building
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro03127178
    152185840001
    BOYD, Alistair Patrick
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    Director
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United KingdomBritish214544820001
    HOGWOOD, Paul Arthur
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    Director
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United KingdomBritish7453920005
    BUHAGIAR, Bryan
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    Secretario designado
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    British900011210001
    GODSELL, Jeanette Louise
    30 St Michaels Road
    GU47 8HE Sandhurst
    Berkshire
    Secretario
    30 St Michaels Road
    GU47 8HE Sandhurst
    Berkshire
    British75623730001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Secretario
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    Secretario
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British75598460002
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    Secretario
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    PEAKE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Wiltshire
    Secretario corporativo
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Wiltshire
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01887672
    55731680011
    BATTLE, David Charles
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    Director
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish111477590002
    BEAUMONT, Peter Stuart
    Badgers Hollow
    Rowhills
    GU9 9AU Farnham
    Surrey
    Director
    Badgers Hollow
    Rowhills
    GU9 9AU Farnham
    Surrey
    British78770280001
    BIBBY, John
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    Director
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    British27995540003
    BRADBURY, Susan Patricia
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40471660002
    BRADLEY, Stephen Michael
    Little London Cottage
    61-62 High Street
    BA12 0EB Heytesbury
    Wiltshire
    Director
    Little London Cottage
    61-62 High Street
    BA12 0EB Heytesbury
    Wiltshire
    EnglandBritish75623610001
    BUHAGIAR, Susan
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    Director designado
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    United KingdomBritish900011200001
    CARTER, Patrick Robert
    Rue De Peuplier 7-9
    FOREIGN 1000 Brussels
    Belgium
    Director
    Rue De Peuplier 7-9
    FOREIGN 1000 Brussels
    Belgium
    British81585030001
    CLARIDGE-WARE, Christopher Maurice
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    The Grange
    Berkshire
    Director
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    The Grange
    Berkshire
    United KingdomBritish5828350004
    CONNELL, Alistair James
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    Director
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish154274870002
    COOMBER, Karen Maria
    Moorhams Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4YG Basingstoke
    7
    Hampshire
    Director
    Moorhams Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4YG Basingstoke
    7
    Hampshire
    EnglandBritish100159270003
    EDMANDS, David James Rosewall
    16 Kings Chase
    TN24 0LQ Ashford
    Kent
    Director
    16 Kings Chase
    TN24 0LQ Ashford
    Kent
    United KingdomBritish118042260001
    HERBERT, James Neville
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    Director
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish164559940002
    HODES, Jonathan
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    Director
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    British79523100001
    JACKSON, John David, Mr.
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Director
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    United KingdomBritish166242060001
    JAMES, Philip William Henry
    Swan Building
    26 Victoria Street
    ML3 0LE Hamilton
    Lanarkshire
    Bermuda
    Director
    Swan Building
    26 Victoria Street
    ML3 0LE Hamilton
    Lanarkshire
    Bermuda
    British33901640005
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    Director
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    KING, Michael Henry
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    Director
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    British14395670002
    KLAIRE, Clare Elizabeth
    1 Chalk Dell Cottages
    Chawton Park Road, Chawton
    GU34 1SW Alton
    Hampshire
    Director
    1 Chalk Dell Cottages
    Chawton Park Road, Chawton
    GU34 1SW Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish75623670001
    MARLEY, Nicholas James
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    Director
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    United KingdomBritish113304050001
    MARLEY, Nicholas James
    2 Nursery Road
    Merton
    SW19 3BT London
    Director
    2 Nursery Road
    Merton
    SW19 3BT London
    British81585110001
    MORLEY, James
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    Director
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    United KingdomUnited Kingdom13374700001
    MORLEY HAM, Stephen Richard
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    Director
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    British80334700004
    MURPHY-COLES, Tobin Mathew
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    Director
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish161141640001
    MURRAY, Alastair Neil
    B303, Gilbert Scott Building
    Scott Avenue
    SW15 3ST Putney
    Director
    B303, Gilbert Scott Building
    Scott Avenue
    SW15 3ST Putney
    United KingdomBritish124855970001
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    Director
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    Director
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001

    ¿Tiene AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A composite debenture
    Creado el 13 dic 2012
    Entregado el 22 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 22 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 07 jun 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A composite debenture
    Creado el 14 nov 2008
    Entregado el 18 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for and on Behalf of the Secured Parties
    Transacciones
    • 18 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2008
    • 14 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 28 feb 2007
    Entregado el 15 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Credit Suisse,London Branch
    Transacciones
    • 15 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 feb 2006
    Entregado el 02 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 02 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 04 jul 2005
    Entregado el 09 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £15,862.50 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The sum of £15,862.50.
    Personas con derecho
    • Amprop Limited
    Transacciones
    • 09 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 14 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 01 may 2004
    Entregado el 11 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    By way of fixed equitable charge all the goodwill and uncalled capital the securities the insurances the rents the fixed plant and equipment by way of first floating charge all those assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mr Rar Francis, Mr Ajm Hutchins, Mr Po Jones
    Transacciones
    • 11 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over shares
    Creado el 01 may 2004
    Entregado el 11 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the charged property to the chargee and upon an enforcement eventall dividends distributions, distributions in specie interest and other monies payable in respect of the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Mr Rar Francis, Mr Ajm Hutchins, Mr Po Jones
    Transacciones
    • 11 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over dividends and shares
    Creado el 30 oct 2003
    Entregado el 01 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,296,450.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The charged shares , any shares or securities issued by way of redemption, bonus, rights, consolidation, sub-division, preference, option or otherwise in respect of the charged shares and all dividends, distributions and other monies payable in respect of charged shares.
    Personas con derecho
    • Paul Brantingham
    Transacciones
    • 01 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over dividends and shares
    Creado el 11 sept 2003
    Entregado el 02 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,296,450.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    By way of a fixed charge the shares and any shares or securities issued by way of redemption, bonus, rights, consolidation, sub-division, preference, option or otherwise in respect of the charged shares. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Paul Brantingham and Mark Brantingham
    Transacciones
    • 02 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rental deposit deed
    Creado el 08 oct 2002
    Entregado el 16 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £42,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Its interest in the deposit account (as defined in the deed) and all money withdrawn from the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Intel Corporation (UK) Limited
    Transacciones
    • 16 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 sept 2016Inicio de la liquidación
    03 abr 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0