WOTSITS BRANDS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WOTSITS BRANDS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04316348 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WOTSITS BRANDS LIMITED?
- Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra WOTSITS BRANDS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WOTSITS BRANDS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INTERCEDE 1756 LIMITED | 05 nov 2001 | 05 nov 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WOTSITS BRANDS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 29 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para WOTSITS BRANDS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WOTSITS BRANDS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de Claire Ellen Stone como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Sigalos como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Sharon Julie Dean como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anwar Ahmed como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 29 dic 2012 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Anwar Yaseen Ahmed como secretario | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sharon Dean como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr John L Sigalos como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew John Macleod el 27 abr 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Joanne Kerry Averiss el 26 abr 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Colin Jones como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Joanne Kerry Averiss el 05 dic 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 25 dic 2010 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 dic 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 26 dic 2009 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Sharon Julie Burrows el 25 abr 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WOTSITS BRANDS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAN, Sharon Julie | Secretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 182653730001 | |||||||
| AVERISS, Joanne Kerry | Director | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | England | British | 57057370001 | |||||
| MACLEOD, Andrew John | Director | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | United Kingdom | British | 62169550002 | |||||
| STONE, Claire Ellen | Director | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | England | British | 111950160001 | |||||
| AHMED, Anwar Yaseen | Secretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 176438060001 | |||||||
| AHMED, Anwar Yaseen | Secretario | 2 St Johns Road Tackley OX5 3AP Kidlington Oxfordshire | British | 96045380002 | ||||||
| BOYD, Stephen Alexander | Secretario | Church Lane LE15 8EY Edith Weston 12 Rutland | British | 142394800001 | ||||||
| DEAN, Sharon Julie | Secretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 148282150002 | |||||||
| WILLIAMS, Mark | Secretario | 6 Setter Combe RG42 2FD Warfield Berkshire | British | 76155240003 | ||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
| AMIN, Salman | Director | 25 Marlborough Place St John's Wood NW8 0PG London | Usa | 116417620001 | ||||||
| BOYD, Stephen Alexander | Director | Church Lane LE15 8EY Edith Weston 12 Rutland | England | British | 142394800001 | |||||
| FRASER, Stanley Walter | Director | 48 Grovewood Close WD3 5PX Chorleywood Hertfordshire | British | 68204280001 | ||||||
| GLENN, Martin Richard | Director | Manor House Stanford Dingley RG7 6LS Reading Berkshire | Uk | British | 61897350002 | |||||
| HAMPTON, Anthony Nicholas Seymour | Director | 1 High Close The Drive WD3 4DZ Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 77901460001 | |||||
| HOWLEY, Simon James | Director | SW19 | British | 77931570001 | ||||||
| JONES, Colin Robert | Director | Links Road HP10 9LY Flackwell Heath 3 Buckinghamshire | England | British | 174775240001 | |||||
| RICH, Michael William | Director designado | Hillfield Gorse Hill Farningham DA4 0JU Dartford Kent | British | 900020860001 | ||||||
| SHARPE, Clive Richard | Director | Knighton Rise LE2 2RE Leicester 18 Leics | England | British | 134995270001 | |||||
| SIGALOS, John L | Director | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | United Kingdom | American | 170690380001 | |||||
| VAN DER EEMS, Jeffrey Peter | Director | 72 Stanley Road East Sheen SW14 7DZ London | England | British | 118890890001 | |||||
| WILLIAMS, Mark | Director | 6 Setter Combe RG42 2FD Warfield Berkshire | British | 76155240003 |
¿Tiene WOTSITS BRANDS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of accession | Creado el 26 feb 2002 Entregado el 05 mar 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All money or liabilities due or to become due from the new charging company (golden wonder group limited) or any other charging company to any secured pary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0