ALUPACK HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALUPACK HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04316677 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALUPACK HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ALUPACK HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 20 Brickfield Road B25 8HE Birmingham |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALUPACK HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MELH 888 LIMITED | 08 feb 2002 | 08 feb 2002 |
| INTERCEDE 1764 LIMITED | 05 nov 2001 | 05 nov 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALUPACK HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALUPACK HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Laurence Steven Bryant como secretario el 14 ago 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Lestyn Shather como secretario el 30 jun 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Laurence Steven Bryant como secretario el 30 jun 2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 nov 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 02 nov 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 34 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sara Mari Thomas como director el 30 abr 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Euro Packaging Jersey Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 dic 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Shabir Majid Alimahomed en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 dic 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 34 páginas | AA | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Marghub Ahmed Shaikh como director el 30 ene 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Lestyn Shather como secretario el 30 ene 2020 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ALUPACK HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSTON, Leon | Director | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | Wales | British | 179527990002 | |||||
| SHAIKH, Marghub Ahmed | Director | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | England | British | 85652210001 | |||||
| AKBAR, Shokat Ali | Secretario | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | 196061840001 | |||||||
| BLAKEN, Stephen Graham | Secretario | Glyn Terrace Blaenclydach CF40 2EG Tonypandy 4 Mid Glamorgan | British | 135666100001 | ||||||
| BRYANT, Laurence Steven | Secretario | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | 310747850001 | |||||||
| GENTRY, Kenneth Victor | Secretario | 1 The Burrows Newton CF36 5AJ Porthcawl Mid Glamorgan | British | 22290440001 | ||||||
| HIND, John Douglas | Secretario | 32 Priory Gardens PE9 2EG Stamford Lincolnshire | British | 68009780002 | ||||||
| O'CONNOR, Julia | Secretario | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | 216418510001 | |||||||
| SHAIKH, Marghub Ahmed | Secretario | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | 201219820001 | |||||||
| SHATHER, Mark Lestyn | Secretario | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | 266783610001 | |||||||
| TAHMASEBI, Khosrow | Secretario | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | 181012250001 | |||||||
| WILLIAMS, David Brian | Secretario | 48 Victoria Road CF64 3HY Penarth Vale Of Glamorgan | British | 6237820001 | ||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
| CAPLIN, Anthony Lindsay | Director | Elm Lodge River Gardens SW6 6NZ London 22 | United Kingdom | British | 139900020001 | |||||
| FAZAL, Abdul Kadir | Director | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | United Kingdom | British | 256646880001 | |||||
| GENTRY, Kenneth Victor | Director | 1 The Burrows Newton CF36 5AJ Porthcawl Mid Glamorgan | British | 22290440001 | ||||||
| HELME, Ian | Director | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | Wales | British | 135666130003 | |||||
| HIND, John Douglas | Director | 32 Priory Gardens PE9 2EG Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 68009780002 | |||||
| HOWLEY, Simon James | Director | SW19 | British | 77931570001 | ||||||
| JOHN, Ian Clive | Director | Tynwald 23a Longfield Drive HP6 5HD Amersham Buckinghamshire | England | British | 114024160001 | |||||
| MAJID, Ibrahim | Director | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | England | British | 255851670001 | |||||
| MCMURRAY, Andrew | Director | The Ridgeway NW11 8QL London 53 | United Kingdom | British | 90394330001 | |||||
| RICH, Michael William | Director designado | Hillfield Gorse Hill Farningham DA4 0JU Dartford Kent | British | 900020860001 | ||||||
| ROWELL, Jack | Director | Middlehill House Middlehill SN13 8QS Box Wiltshire | British | 83086770001 | ||||||
| SMITH, David Leslie | Director | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | England | British | 189639980001 | |||||
| TAHMASEBI, Khosrow | Director | The Paddocks 3 Lavender Close CR3 5DW Chaldon Common Surrey | United Kingdom | British | 38518070001 | |||||
| THOMAS, Sara Mari | Director | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | Wales | British | 203006550001 | |||||
| WILLIAMS, David Brian | Director | 48 Victoria Road CF64 3HY Penarth Vale Of Glamorgan | British | 6237820001 | ||||||
| YOUNG, John Alexander | Director | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | United Kingdom | British | 213099570001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALUPACK HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Packaging Jersey Limited | 22 dic 2020 | Esplanade JE1 1GH Jersey 2nd Floor, Gaspe House Jersey | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Shabir Majid Alimahomed | 06 abr 2016 | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: United Arab Emirates | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ALUPACK HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 08 mar 2002 Entregado el 11 mar 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture deed | Creado el 08 mar 2002 Entregado el 09 mar 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture deed | Creado el 08 mar 2002 Entregado el 09 mar 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0