PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04317596 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
- Servicios de apoyo a la educación (85600) / Educación
¿Dónde se encuentra PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Park Row LS1 5AB Leeds United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BROOMCO (2702) LIMITED | 06 nov 2001 | 06 nov 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 05 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Ms Rosanagh Frances Buhl-Nielsen como director el 31 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Frank David Laing como director el 31 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 17 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Kevin Alistair Cunningham como director el 25 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Thomas Solley como director el 31 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Frank David Laing como director el 31 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 17 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Nicola Covington como director el 19 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Martin Timothy Smith como director el 19 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de John Mcdonagh como director el 10 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Kevin Alistair Cunningham como director el 10 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 17 páginas | AA | ||
Modification des détails de Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 dic 2022 | 2 páginas | PSC05 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr John Stephen Gordon como director el 30 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr John Mcdonagh como director el 30 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Kenneth Johnstone como director el 30 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de John Stephen Gordon como director el 30 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Dalmore Capital Limited Watling House - 5th Floor 33 Cannon Street London EC4M 5SB England a 1 Park Row Leeds LS1 5AB el 05 jun 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022 | 16 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 06 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Resolis Limited como secretario el 15 mar 2022 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Wendy Lisa Rapley como secretario el 15 mar 2022 | 1 páginas | TM02 | ||
¿Quiénes son los directivos de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLIS LIMITED | Secretario corporativo | c/o Pinsent Mason Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 285489620001 | ||||||||||
| BUHL-NIELSEN, Rosanagh Frances | Director | 280 Bishopsgate EC2M 4AG London Abrdn Plc England England | United Kingdom | British | 261553600002 | |||||||||
| COVINGTON, Nicola | Director | 280 Bishopsgate EC2M 4AG London Abrdn Plc England England | United Kingdom | British | 207391580001 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Director | 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Dalmore Capital, Caledonian Exchange Scotland | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| BRADBURY, Trevor | Secretario | 22 East Park Farm Drive Charvil RG10 9UL Reading Berkshire | British | 47884750003 | ||||||||||
| LEWIS, Martin | Secretario | Apartment 503 87 Branston Street B18 6BT Birmingham | British | 79300270005 | ||||||||||
| LYNCH, Valerie Ann | Secretario | 6 Charvil House Road Charvil RG10 9RD Reading Berkshire | British | 68872030002 | ||||||||||
| RAPLEY, Wendy Lisa, Mrs. | Secretario | 400 Thames Valley Park Drive Thames Valley Park RG6 1PT Reading C/O Resolis Limited Berkshire England | British | 74196190009 | ||||||||||
| SMERDON, Leigh | Secretario | 1 Cedar Grove The Hedgerows Great Wyrley WS6 6QH Walsall West Midlands | Other | 89075910001 | ||||||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 | |||||||||||
| BIRLEY SMITH, Gaynor | Director | Common House Ivington Court Ivington HR6 0JW Leominster Herefordshire | England | English | 83779370002 | |||||||||
| CUNNINGHAM, Kevin Alistair | Director | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8 EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | 271263600001 | |||||||||
| DALE, Robert | Director | George Road 395 George Road Erdington B23 7RZ Birmingham 395 England | England | British | 134398440001 | |||||||||
| DARLING, Andrew David | Director | 4 Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow West Lothian | British | 73218540001 | ||||||||||
| DICKIE, Timothy John | Director | 51 Summerside Place EH6 4NY Edinburgh | British | 107164130002 | ||||||||||
| DICKINSON, Victoria Helen | Director | Flat 5 243a Wimbledon Park Road SW18 5RJ London | British | 80242100001 | ||||||||||
| FIELD, Christopher Richard | Director | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Limited England | United Kingdom | British | 117601990003 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Director | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Director | c/o Dalmore Capital 19a, Canning Street EH3 8EG Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| GOYAL, Rajan | Director | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | 94399020001 | |||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Director | EH4 5EG Edinburgh 60 Hillhouse Road Edinburgh Scotland | United Kingdom | British | 53299620003 | |||||||||
| LAING, Frank David | Director | St Andrew Square EH2 2AH Edinburgh 6 United Kingdom | Scotland | British | 256185820002 | |||||||||
| LOWRY, Mark | Director | 10 Ravelston House Park EH4 3LU Edinburgh | Scotland | British | 110781080001 | |||||||||
| MALLION, Stephen John | Director | Interserve House Ruscombe Park, Twyford RG10 9JU Reading Interserve House Berkshire England | England | British | 139451450005 | |||||||||
| MCDONAGH, John | Director | 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh 2nd Floor Caledonian Exchange United Kingdom | England | British | 192240500002 | |||||||||
| MELIZAN, Bruce Anthony | Director | Willowmead Orchard Road RG10 0SD Hurst Berkshire | United Kingdom | British,Trinidadian | 92905500001 | |||||||||
| PHILIPSZ, Joseph Eugene | Director | 200 Aldersgate Street EC1A 2ND London 17th Floor England | United Kingdom | British,Irish | 83107910002 | |||||||||
| RINGROSE, Adrian Michael | Director | 66 Bedford Avenue EN5 2ER Barnet Hertfordshire | British | 74958050001 | ||||||||||
| SHAKSHIR, Fuad | Director | Skeena Hill London DW18 5PW 57 | British | 75557050004 | ||||||||||
| SMITH, Martin Timothy | Director | 9 Carlingnose Point KY11 1ER North Queensferry | Scotland | British | 82478070001 | |||||||||
| SOLLEY, Christopher Thomas | Director | 40 Princes Street EH2 2BY Edinburgh Aberdeen Asset Management Plc Scotland | United Kingdom | British | 166666620001 | |||||||||
| VINCE, Robert David | Director | 10 Wasperton Village CV35 8EB Warwick Warwickshire | British | 69268810001 | ||||||||||
| WENTZELL, Graham John | Director | 1 Tithe Court Glebelands Road RG40 1DS Wokingham Berkshire | British | 64466870001 | ||||||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Director corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146610001 | |||||||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browning Pfi Holdings Limited | 06 abr 2016 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited | 06 abr 2016 | Bishopsgate EC2M 4AG London 280 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0