PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED

PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04317596
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
    • Servicios de apoyo a la educación (85600) / Educación

    ¿Dónde se encuentra PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BROOMCO (2702) LIMITED06 nov 200106 nov 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta21 nov 2026
    Próxima declaración de confirmación vence05 dic 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta21 nov 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Ms Rosanagh Frances Buhl-Nielsen como director el 31 ene 2026

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Frank David Laing como director el 31 ene 2026

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 21 nov 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Kevin Alistair Cunningham como director el 25 ago 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Christopher Thomas Solley como director el 31 ene 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Frank David Laing como director el 31 ene 2025

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 15 nov 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    17 páginasAA

    Nombramiento de Ms Nicola Covington como director el 19 ene 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Martin Timothy Smith como director el 19 ene 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Mcdonagh como director el 10 ene 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Kevin Alistair Cunningham como director el 10 ene 2024

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    17 páginasAA

    Modification des détails de Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 dic 2022

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 03 nov 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr John Stephen Gordon como director el 30 jun 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr John Mcdonagh como director el 30 jun 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peter Kenneth Johnstone como director el 30 jun 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Stephen Gordon como director el 30 jun 2023

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Dalmore Capital Limited Watling House - 5th Floor 33 Cannon Street London EC4M 5SB England a 1 Park Row Leeds LS1 5AB el 05 jun 2023

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2022

    16 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 nov 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Resolis Limited como secretario el 15 mar 2022

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Wendy Lisa Rapley como secretario el 15 mar 2022

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RESOLIS LIMITED
    c/o Pinsent Mason
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Secretario corporativo
    c/o Pinsent Mason
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro13181806
    285489620001
    BUHL-NIELSEN, Rosanagh Frances
    280 Bishopsgate
    EC2M 4AG London
    Abrdn Plc
    England
    England
    Director
    280 Bishopsgate
    EC2M 4AG London
    Abrdn Plc
    England
    England
    United KingdomBritish261553600002
    COVINGTON, Nicola
    280 Bishopsgate
    EC2M 4AG London
    Abrdn Plc
    England
    England
    Director
    280 Bishopsgate
    EC2M 4AG London
    Abrdn Plc
    England
    England
    United KingdomBritish207391580001
    GORDON, John Stephen
    19a Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    C/O Dalmore Capital, Caledonian Exchange
    Scotland
    Director
    19a Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    C/O Dalmore Capital, Caledonian Exchange
    Scotland
    ScotlandBritish203724200001
    BRADBURY, Trevor
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    Secretario
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    British47884750003
    LEWIS, Martin
    Apartment 503
    87 Branston Street
    B18 6BT Birmingham
    Secretario
    Apartment 503
    87 Branston Street
    B18 6BT Birmingham
    British79300270005
    LYNCH, Valerie Ann
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    Secretario
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    British68872030002
    RAPLEY, Wendy Lisa, Mrs.
    400 Thames Valley Park Drive
    Thames Valley Park
    RG6 1PT Reading
    C/O Resolis Limited
    Berkshire
    England
    Secretario
    400 Thames Valley Park Drive
    Thames Valley Park
    RG6 1PT Reading
    C/O Resolis Limited
    Berkshire
    England
    British74196190009
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Secretario
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    BIRLEY SMITH, Gaynor
    Common House
    Ivington Court Ivington
    HR6 0JW Leominster
    Herefordshire
    Director
    Common House
    Ivington Court Ivington
    HR6 0JW Leominster
    Herefordshire
    EnglandEnglish83779370002
    CUNNINGHAM, Kevin Alistair
    Caledonian Exchange
    19a Canning Street
    EH3 8 EG Edinburgh
    Dalmore Capital
    United Kingdom
    Director
    Caledonian Exchange
    19a Canning Street
    EH3 8 EG Edinburgh
    Dalmore Capital
    United Kingdom
    ScotlandBritish271263600001
    DALE, Robert
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    Director
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    EnglandBritish134398440001
    DARLING, Andrew David
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    Director
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    British73218540001
    DICKIE, Timothy John
    51 Summerside Place
    EH6 4NY Edinburgh
    Director
    51 Summerside Place
    EH6 4NY Edinburgh
    British107164130002
    DICKINSON, Victoria Helen
    Flat 5
    243a Wimbledon Park Road
    SW18 5RJ London
    Director
    Flat 5
    243a Wimbledon Park Road
    SW18 5RJ London
    British80242100001
    FIELD, Christopher Richard
    3rd Floor, 3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Limited
    England
    Director
    3rd Floor, 3-5 Charlotte Street
    M1 4HB Manchester
    C/O Albany Spc Services Limited
    England
    United KingdomBritish117601990003
    GILLESPIE, Kenneth William
    7 Shaws Crescent
    EH26 0RE Milton Bridge
    Midlothian
    Director
    7 Shaws Crescent
    EH26 0RE Milton Bridge
    Midlothian
    ScotlandBritish105139700001
    GORDON, John Stephen
    c/o Dalmore Capital
    19a, Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    Director
    c/o Dalmore Capital
    19a, Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Scotland
    ScotlandBritish203724200001
    GOYAL, Rajan
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritish94399020001
    JOHNSTONE, Peter Kenneth
    EH4 5EG Edinburgh
    60 Hillhouse Road
    Edinburgh
    Scotland
    Director
    EH4 5EG Edinburgh
    60 Hillhouse Road
    Edinburgh
    Scotland
    United KingdomBritish53299620003
    LAING, Frank David
    St Andrew Square
    EH2 2AH Edinburgh
    6
    United Kingdom
    Director
    St Andrew Square
    EH2 2AH Edinburgh
    6
    United Kingdom
    ScotlandBritish256185820002
    LOWRY, Mark
    10 Ravelston House Park
    EH4 3LU Edinburgh
    Director
    10 Ravelston House Park
    EH4 3LU Edinburgh
    ScotlandBritish110781080001
    MALLION, Stephen John
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish139451450005
    MCDONAGH, John
    19a Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    2nd Floor Caledonian Exchange
    United Kingdom
    Director
    19a Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    2nd Floor Caledonian Exchange
    United Kingdom
    EnglandBritish192240500002
    MELIZAN, Bruce Anthony
    Willowmead
    Orchard Road
    RG10 0SD Hurst
    Berkshire
    Director
    Willowmead
    Orchard Road
    RG10 0SD Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritish,Trinidadian92905500001
    PHILIPSZ, Joseph Eugene
    200 Aldersgate Street
    EC1A 2ND London
    17th Floor
    England
    Director
    200 Aldersgate Street
    EC1A 2ND London
    17th Floor
    England
    United KingdomBritish,Irish83107910002
    RINGROSE, Adrian Michael
    66 Bedford Avenue
    EN5 2ER Barnet
    Hertfordshire
    Director
    66 Bedford Avenue
    EN5 2ER Barnet
    Hertfordshire
    British74958050001
    SHAKSHIR, Fuad
    Skeena Hill
    London
    DW18 5PW
    57
    Director
    Skeena Hill
    London
    DW18 5PW
    57
    British75557050004
    SMITH, Martin Timothy
    9 Carlingnose Point
    KY11 1ER North Queensferry
    Director
    9 Carlingnose Point
    KY11 1ER North Queensferry
    ScotlandBritish82478070001
    SOLLEY, Christopher Thomas
    40 Princes Street
    EH2 2BY Edinburgh
    Aberdeen Asset Management Plc
    Scotland
    Director
    40 Princes Street
    EH2 2BY Edinburgh
    Aberdeen Asset Management Plc
    Scotland
    United KingdomBritish166666620001
    VINCE, Robert David
    10 Wasperton Village
    CV35 8EB Warwick
    Warwickshire
    Director
    10 Wasperton Village
    CV35 8EB Warwick
    Warwickshire
    British69268810001
    WENTZELL, Graham John
    1 Tithe Court
    Glebelands Road
    RG40 1DS Wokingham
    Berkshire
    Director
    1 Tithe Court
    Glebelands Road
    RG40 1DS Wokingham
    Berkshire
    British64466870001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Director corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PYRAMID SCHOOLS (TAMESIDE) HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Browning Pfi Holdings Limited
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    06 abr 2016
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUk Company Law
    Lugar de registroEngland
    Número de registro04557638
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited
    Bishopsgate
    EC2M 4AG London
    280
    England
    06 abr 2016
    Bishopsgate
    EC2M 4AG London
    280
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUk Company Law
    Lugar de registroEngland
    Número de registro06632304
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0