HRWF (LEEDS 2) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | HRWF (LEEDS 2) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04318260 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HRWF (LEEDS 2) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HRWF (LEEDS 2) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 9th Floor 201 Bishopsgate EC2M 3BN London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HRWF (LEEDS 2) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GRANTCHESTER NOMINEES (LEEDS 2) LIMITED | 07 nov 2001 | 07 nov 2001 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HRWF (LEEDS 2) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HRWF (LEEDS 2) LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HRWF (LEEDS 2) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael John Lawson Sales el 30 jul 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael Anthony Ussher el 25 jul 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Mark Griffiths el 25 jul 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Claire Louise Tily el 25 jul 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nigel Ian Bartram el 25 jul 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Th Re Corporate Secretarial Services Limited como secretario el 01 abr 2014 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Henderson Secretarial Services Limited como secretario el 01 abr 2014 | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 201 Bishopsgate London EC2M 3AE el 09 abr 2014 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 nov 2013 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael John Lawson Sales el 27 jul 2011 | 6 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Wallace Anderson como director el 28 mar 2013 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roger Benjamin Ely como director el 12 dic 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Michael Anthony Ussher como director el 12 dic 2012 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 nov 2012 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 nov 2011 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de William Wallace Anderson como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de HRWF (LEEDS 2) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH RE CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom |
| 188415810001 | ||||||||||
| BARTRAM, Nigel Ian | Director | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 147069720001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Mark | Director | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 146681760001 | |||||||||
| SALES, Michael John Lawson | Director | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 163411440001 | |||||||||
| TILY, Claire Louise | Director | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 154521600001 | |||||||||
| USSHER, Michael Anthony | Director | Bishopsgate EC2M 3BN London 201 United Kingdom | England | British | 174875400001 | |||||||||
| HENDERSON ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Director corporativo | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 | 73737310001 | |||||||||||
| CARPENTER, Venetia Caroline | Secretario designado | Wanshurst Green Farm Marden TN12 9DF Tonbridge Kent | British | 900022970001 | ||||||||||
| HOLLOCKS, Ian Michael | Secretario | 22 Fairholme Avenue RM2 5UU Gidea Park Essex | British | 61055270001 | ||||||||||
| HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 | 6118210006 | |||||||||||
| ALFORD, Nicholas Brian Treseder | Director | The Pines North Road HP4 3DX Berkhamsted Hertfordshire | Great Britain | British | 126970360001 | |||||||||
| ANDERSON, William Wallace | Director | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 United Kingdom | England | British | 2894560001 | |||||||||
| ELY, Roger Benjamin | Director | Bishopsgate EC2M 3AE London 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 69707840001 | |||||||||
| EVANS, Christopher Mark Stephen | Director designado | 12 Criffel Avenue Streatham Hill SW2 4AZ London | British | 900022960001 | ||||||||||
| HEWSON, Andrew Nicholas | Director | Abesters Fernden Lane Blackdown GU27 3BS Haslemere Surrey | British | 8607090005 | ||||||||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Director | 15 Wildwood Road Hampstead Garden Suburb NW11 6UL London | England | British | 3470530003 | |||||||||
| WALTON, Timothy Paul | Director | Ivy House Church Row Meole Brace SY3 9EY Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 59971310002 |
¿Tiene HRWF (LEEDS 2) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 18 oct 2006 Entregado el 03 nov 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The f/h land to the east of great cambridge road. Enfield k/a as enfield retail park t/no EGL316564 and the l/h land and buildings on the north east side of great ancoats street, manchester, greater manchester k/a as central retail park t/no GM512140 and MAN39842 the f/h property k/a the belvedere retail park, brunton lane, newcastle-upon-tyne (including barratt house) t/nos TY360155, TY237793, TY13551 and TY233764 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security agreement | Creado el 18 ene 2006 Entregado el 03 feb 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H land to the east of great cambridge road enfield k/a enfield retail park t/n EGL316564 except for part, l/h land k/a central retail park great ancoats street manchester t/n GM512140, f/h land k/a the belvedere retail park brunton lane newcastle upon tyne t/n TY360155 and TY237793 for details of further properties charged please refer to form 395 all plant and machinery all monies all benefits in respect of the insurances all of its book and other debts first floating charge all its assets forming part of the trust fund. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A security agreement | Creado el 21 mar 2002 Entregado el 03 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción 1). all that freehold land on the north west side gelderd road birstall known as the west yorkshire retail park birstall t/no;-WYK621393 2). all that freehold land known as central retail park rooksley milton keynes T./no. BM219388 3). all that freehold land known as rooksley retail park milton keynes T./no;-BM203571 and all assets charged by way of fixed and floating charge under the terms of the charge.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0