BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED

BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04319671
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Suite 4, First Floor Honeycomb
    The Watermark
    NE11 9SZ Gateshead
    Tyne & Wear
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BPT BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED08 mar 200208 mar 2002
    HAMSARD 2427 LIMITED08 nov 200108 nov 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2025
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 may 2026
    Próxima declaración de confirmación vence15 may 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta01 may 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2024

    17 páginasAA

    legacy

    43 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2023

    16 páginasAA

    legacy

    41 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2022

    16 páginasAA

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    41 páginasPARENT_ACC

    legacy

    5 páginasGUARANTEE2

    Cambio de datos del director Mr Antony Lewis Pierce el 17 may 2022

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Reversions Financing (No. 1) 2011 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 mar 2022

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Suite 4, First Floor the Honeycomb the Watermark Gateshead Tyne & Wear NE11 9SZ England a Suite 4, First Floor Honeycomb the Watermark Gateshead Tyne & Wear NE11 9SZ el 02 mar 2022

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2021

    19 páginasAA

    Modification des détails de Reversions Financing (No. 1) 2011 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov 2021

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de Cross House Westgate Road Newcastle upon Tyne NE1 4XX England a Suite 4, First Floor the Honeycomb the Watermark Gateshead Tyne & Wear NE11 9SZ el 02 nov 2021

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 01 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Antony Lewis Pierce el 01 mar 2021

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020

    16 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARBER, Paul Trevor
    Honeycomb
    The Watermark
    NE11 9SZ Gateshead
    Suite 4, First Floor
    Tyne & Wear
    England
    Director
    Honeycomb
    The Watermark
    NE11 9SZ Gateshead
    Suite 4, First Floor
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritish121775760002
    PIERCE, Antony Lewis
    Honeycomb
    The Watermark
    NE11 9SZ Gateshead
    Suite 4, First Floor
    Tyne & Wear
    England
    Director
    Honeycomb
    The Watermark
    NE11 9SZ Gateshead
    Suite 4, First Floor
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritish156315340004
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Secretario
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Secretario
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    HALLIWELL, Christine
    113 Drub Lane
    BD19 4BZ Cleckheaton
    West Yorkshire
    Secretario
    113 Drub Lane
    BD19 4BZ Cleckheaton
    West Yorkshire
    British66463330001
    MCGHIN, Adam
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    Secretario
    St. James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    Tyne And Wear
    206239550001
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Secretario
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    HSE SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Secretario corporativo
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580006
    BUTTERWORTH, Gary Ronald
    129 Chingford Avenue
    E4 6RG London
    Director
    129 Chingford Avenue
    E4 6RG London
    British63723110001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Follifoot House
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Director
    Follifoot House
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    UkBritish156117090001
    CRUMBLEY, Brian Aidan
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish8495220002
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    St James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    EnglandBritish74581390003
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Director
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish65421150003
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Director
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    DIXON, Alistair William
    245 Kennington Road
    SE11 6BY London
    Director
    245 Kennington Road
    SE11 6BY London
    United KingdomBritish49174270004
    GREENWOOD, Mark
    Citygate
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish154194730002
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Citygate
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Director
    Citygate
    St James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish60099210003
    ON, Nicholas Peter
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    Director
    Saint James' Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Citygate
    United Kingdom
    United KingdomBritish135860930002
    PRATT, Andrew Michael
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    Director
    Shadybrook, Beeches Drive
    Farnham Common
    SL2 3JT Slough
    Berkshire
    EnglandBritish123314130002
    ROBSON, Mark Jeremy
    Albury Park Road
    NE30 2SH Tynemouth
    12
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Director
    Albury Park Road
    NE30 2SH Tynemouth
    12
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish97977930003
    SCHWERDT, Peter Christopher George
    Newtown House
    Alton Barnes
    SN8 4LB Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Newtown House
    Alton Barnes
    SN8 4LB Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish44923060004
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Director
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    British94640230001
    WALL, John Robert
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    Director
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish72368120001
    WINDLE, Michael Patrick
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    Director
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish43646700001
    YUDOLPH, Debra Rachel
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    Director
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    EnglandBritish105582680001
    HSE DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    England
    Director corporativo
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    England
    73774730002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BRIDGEWATER (HOME REVERSIONS NUMBER 2) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Honeycomb
    The Watermark
    NE11 9SZ Gateshead
    Suite 4, First Floor
    Tyne & Wear
    England
    06 abr 2016
    Honeycomb
    The Watermark
    NE11 9SZ Gateshead
    Suite 4, First Floor
    Tyne & Wear
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEnglish Law
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07783862
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0