TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED

TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04328016
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Windsor House 42-50 42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TUBE LINES LIMITED28 ene 200228 ene 2002
    2164TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED23 nov 200123 nov 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 08 may 2014

    • Capital: GBP 2
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 28 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Howard Ernest Carter como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Keith Williams como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Daniel Moylan como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    22 páginasAA

    Cambio de datos del director Sir Peter Gerard Hendy el 12 mar 2013

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Christopher Garnett como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 28 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    22 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    20 páginasAA

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2010 au 31 mar 2011

    1 páginasAA01

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 28 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O the Company Secretary the Sherard Building Edmund Halley Road Oxford Oxfordshire OX4 4DQ United Kingdom

    1 páginasAD02

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado

    1 páginasAD04

    Resoluciones

    Resolutions
    23 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Resoluciones

    Resolutions
    23 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CARTER, Howard Earnest
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Secretario
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    British152621500001
    JONES, Martin Patrick William
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Secretario
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    British152674210001
    ALLEN, Stephen David
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Director
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritishFinance Director91156870001
    CARTER, Howard Ernest
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Director
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    United KingdomBritishGereral Counsel115261680003
    HENDY, Peter Gerard, Sir
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Director
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritishCommissioner For Transport62384480001
    LING, Elaine Linda Kirby
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Secretario
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    British103202830002
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Secretario corporativo
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    70053320013
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Secretario corporativo
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    109588620001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secretario designado corporativo
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ADAMS, Michael Augustine
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    Director
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    EnglandBritishPresident Civil100265760001
    ADAMS, Michael Augustine
    Comforts Place
    Tandridge Lane
    RH7 6LW Lingfield
    Surrey
    Director
    Comforts Place
    Tandridge Lane
    RH7 6LW Lingfield
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director100265760001
    BAILEY, Michael Cleveland
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    United Kingdom
    Director
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    United Kingdom
    CanadianBusiness Executive110217530001
    BASSILY, Fady Philip
    6 Physic Place
    Royal Hospital Road
    SW3 4HQ London
    Director
    6 Physic Place
    Royal Hospital Road
    SW3 4HQ London
    UsaSenior Vice President95885620001
    BEGG, David Andrew
    67 Victoria Wharf
    46 Narrow Street
    E14 8DD London
    Director
    67 Victoria Wharf
    46 Narrow Street
    E14 8DD London
    EnglandBritishLecturer76645940003
    CARLISLE, Celia Diana
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    Director
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    United KingdomBritishProject Finance63756390001
    COPELAND, Ian Christopher
    Oakwood
    One Pine Street Apartment 2002
    FOREIGN San Francisco
    California 94111
    Usa
    Director
    Oakwood
    One Pine Street Apartment 2002
    FOREIGN San Francisco
    California 94111
    Usa
    UsaManaging Director Finance80111500002
    CORBIN, Brian James
    71 Woodwarde Road
    Dulwich Village
    SE22 8UN London
    Director
    71 Woodwarde Road
    Dulwich Village
    SE22 8UN London
    BritishBusiness Executive87942120001
    COTTRELL, Keith
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    EnglandBritishInvestment Manager88691090003
    CUNNINGHAM, Anthony
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Brafferton
    YO61 2NZ York
    The Old Vicarage
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director135811090001
    DOVE, Robert Wallace
    Tara Cavendish Road
    Saint Georges Hill
    KT13 0JT Weybridge
    Surrey
    Director
    Tara Cavendish Road
    Saint Georges Hill
    KT13 0JT Weybridge
    Surrey
    BritishManaging Director80507460001
    ELKHOULY, Wael Nabil
    19 Acacia Avenue
    HA4 8RQ Eastcote
    Middlesex
    Director
    19 Acacia Avenue
    HA4 8RQ Eastcote
    Middlesex
    EgyptianProject Development And Financ86216370001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Director
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    BritishDirector50174710001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Director
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    BritishDirector50174710001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector61515760002
    FENTON, Christopher Victor
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director114610580002
    FIELD, Malcolm David, Sir
    21 Embankment Gardens
    SW3 4LW London
    Director
    21 Embankment Gardens
    SW3 4LW London
    EnglandBritishCompany Director74857040002
    GARNETT, Christopher William Maxwell
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    Director
    42-50 Victoria Street
    SW1H 0TL London
    Windsor House 42-50
    EnglandBritishDirector120894870001
    GARTSHORE, Andrew Robert
    6 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NX London
    Director
    6 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NX London
    New ZealanderBusiness Executive87942040001
    GORDON, Ray
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    Director
    29 Carrs Meadow
    Escrick
    YO19 6JZ York
    North Yorkshire
    BritishChartered Quantity Surveyor102379260001
    GRENFELL, Eric
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    United Kingdom
    Director
    Pilgrim Street
    5th Floor
    EC4V 6RN London
    11
    United Kingdom
    AmericanPresident Bechtel Enterprises102348350001
    HUI, Carol
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishLawyer144634860001
    HYDE, Kevin Oliver
    12 Mount Parade
    YO24 4AB York
    Director
    12 Mount Parade
    YO24 4AB York
    BritishDirector66509100002
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Director
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector57954340003
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Director
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    SpanishGroup Finance Director93348510004
    LEZALA, Andrew Peter
    11 Finch Crescent
    Mickleover
    DE3 0TT Derby
    Derbyshire
    Director
    11 Finch Crescent
    Mickleover
    DE3 0TT Derby
    Derbyshire
    BritishChartered Engineer85889200001

    ¿Tiene TUBE LINES (HOLDINGS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge by way of assignment
    Creado el 12 may 2004
    Entregado el 27 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of the company's rights in respect of clauses 3 and 4 of the equity subscription agreement dated 12TH may 2004. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 27 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 04 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 12 may 2004
    Entregado el 14 may 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower to any borrower secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The borrower shares and the issuer shares, rights under the declaration trust, benefits by way of conversion, redemption, bonus, preference option or otherwise in respect of the borrower shares or any of the issuer shares floating charge undertaking and all property assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Intermediary Corporation PLC as the Borrower Security Trustee
    Transacciones
    • 14 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 06 jul 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Mortgage over shares
    Creado el 08 ene 2003
    Entregado el 09 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from infraco jnp limited to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The shares being the 4,499,991 shares in the capital of the borrower issued in the name of the company and all rights moneys benefits and other properties. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale (London Branch) (as Security Trustee for the Senior Lenders)
    Transacciones
    • 09 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment agreement
    Creado el 31 dic 2002
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its rights in respect of clauses 3 (ebl subscription obligations) and 4 (security for ebl subscription obligations) of the equity subscription agreement.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A debenture and share mortgage
    Creado el 31 dic 2002
    Entregado el 10 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of equitable mortgage and fixed charge the shares, by way of charge all rights moneys benefits and other properties which may from time to time accrue or be offered or arise by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cit Group Structured Finance (UK) Limited as Mezzanine Security Trustee for Itself and Onbehalf of the Secured Parties
    Transacciones
    • 10 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A floating charge and share mortgage
    Creado el 31 dic 2002
    Entregado el 02 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any senior creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The shares, all rights moneys benefits and other properties which may from time to time accrue or be offered or arise by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares. A first floating charge over the undertaking and all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale (London Branch) the Security Trustee for the Senior Lenders
    Transacciones
    • 02 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 09 sept 2002
    Entregado el 19 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from jubilee rail limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of security the right to receive the amount of up to £11,933,933 (exclusive of value added tax) payable under or in connection with a letter agreement dated 28 august 2002. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 11 ene 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0