CREDENTIAL WTS LIMITED

CREDENTIAL WTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCREDENTIAL WTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04329137
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CREDENTIAL WTS LIMITED?

    • Recuperación de materiales clasificados (38320) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación

    ¿Dónde se encuentra CREDENTIAL WTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Bede House St Cuthberts Way
    Aycliffe Industrial Park
    DL5 6DX Newton Aycliffe
    County Durham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CREDENTIAL WTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AUTOMOTIVE WASTE SOLUTIONS LIMITED04 feb 200204 feb 2002
    TREECROWN LIMITED26 nov 200126 nov 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CREDENTIAL WTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para CREDENTIAL WTS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CREDENTIAL WTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2015

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 nov 2015

    Estado de capital el 03 nov 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    17 páginasAA

    Registro de la carga 043291370013, creada el 02 dic 2014

    15 páginasMR01

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 oct 2014

    Estado de capital el 28 oct 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de Andrea Tidd como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 oct 2013

    Estado de capital el 30 oct 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cambio de datos del director Dr Andrea Jayne Tidd el 14 oct 2013

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Dr Andrea Jayne Tidd como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Peter Hinton el 22 jul 2013

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    16 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Andrew Peter Hinton el 19 jul 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Nicholas Andrew Wyatt el 19 jul 2013

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    15 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Cese del nombramiento de Alastair Cooper como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alastair Cooper como secretario

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de CREDENTIAL WTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HINTON, Andrew Peter, Mr.
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    5a
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    5a
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector114646030002
    WYATT, Nicholas Andrew
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    5a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    5a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector73704370003
    CHEESEBROUGH, William Graham
    9 Shaftesbury Avenue
    LS8 1DR Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    9 Shaftesbury Avenue
    LS8 1DR Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant79568320001
    COOPER, Alastair
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    BritishDirector75329850001
    JORDAN, Michael
    Azahara, 69 Calle Ballesteros
    Urb. San Roque Club, 11360 San Roque
    LE10 0FT Cadiz
    Spain 11360
    Secretario
    Azahara, 69 Calle Ballesteros
    Urb. San Roque Club, 11360 San Roque
    LE10 0FT Cadiz
    Spain 11360
    British42732170006
    PORTER, Derek
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    Secretario
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    British47585310001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BAVAIRD, David Wilson
    66 Linskill Terrace
    Tynemouth
    NE30 2EP North Shields
    Tyne & Wear
    Director
    66 Linskill Terrace
    Tynemouth
    NE30 2EP North Shields
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector123673180001
    CHEESEBROUGH, William Graham
    9 Shaftesbury Avenue
    LS8 1DR Leeds
    West Yorkshire
    Director
    9 Shaftesbury Avenue
    LS8 1DR Leeds
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant79568320001
    CLAPHAM, Ronald Barrie
    Flat 8/2, 12 Lancefield Quay
    G3 8HR Glasgow
    Director
    Flat 8/2, 12 Lancefield Quay
    G3 8HR Glasgow
    ScotlandBritishDirector101562830001
    COOPER, Alastair
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector75329850001
    FISHWICK, Michael
    3 Dalton Lane
    Burton
    LA6 1NG Carnforth
    Lancashire
    Director
    3 Dalton Lane
    Burton
    LA6 1NG Carnforth
    Lancashire
    BritishManaging Director107989450001
    GIBSON, Graham
    94 Castle Green
    Westbrook
    WA5 7XA Warrington
    Director
    94 Castle Green
    Westbrook
    WA5 7XA Warrington
    BritishCommercial Director68365490003
    JORDAN, Michael
    Azahara, 69 Calle Ballesteros
    Urb. San Roque Club, 11360 San Roque
    LE10 0FT Cadiz
    Spain 11360
    Director
    Azahara, 69 Calle Ballesteros
    Urb. San Roque Club, 11360 San Roque
    LE10 0FT Cadiz
    Spain 11360
    BritishCompany Director42732170006
    PATTERSON, Stephen
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    Ls17 9lf
    United Kingdom
    Director
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    Ls17 9lf
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector188301290001
    PATTERSON, Stephen
    Peartree Cottage
    Cotherstone
    DL12 9NL Barnard Castle
    County Durham
    Director
    Peartree Cottage
    Cotherstone
    DL12 9NL Barnard Castle
    County Durham
    BritishDirector119928180001
    PORTER, Derek
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    Director
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    United KingdomBritishCompany Director47585310001
    TEMPLEMAN, Rodney Mark
    The Coach House
    Hurstwood Lane
    TN4 8YA Royal Tunbridge Wells
    Director
    The Coach House
    Hurstwood Lane
    TN4 8YA Royal Tunbridge Wells
    BritishManager79976450002
    TIDD, Andrea Jayne
    Bede House St Cuthberts Way
    Aycliffe Industrial Park
    DL5 6DX Newton Aycliffe
    County Durham
    Director
    Bede House St Cuthberts Way
    Aycliffe Industrial Park
    DL5 6DX Newton Aycliffe
    County Durham
    EnglandBritishNone175875650001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Director designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    ¿Tiene CREDENTIAL WTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 02 dic 2014
    Entregado el 16 dic 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    'I. All freehold or leasehold property of the company with all present and future buildings, fixtures (trade fixtures) plant and machinery which are on such property. Ii. All patents, patent applications, inventions, trade marks, service marks (whether registered or no), trade names, design rights, registered designs, copyrights, know-how, trade secrets, rights ion computer software and any other intellectual or intangible property rights (including the benefit of any licences or consents.'.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Skipton Business Finance LTD
    Transacciones
    • 16 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    Mortgage debenture
    Creado el 21 oct 2008
    Entregado el 31 oct 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the debtor or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Nicholas Wyatt
    Transacciones
    • 31 oct 2008Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 21 oct 2008
    Entregado el 31 oct 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the debtor or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew Hinton
    Transacciones
    • 31 oct 2008Registro de un cargo (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 21 oct 2008
    Entregado el 24 oct 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 24 oct 2008Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 oct 2007
    Entregado el 02 nov 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and ce holdings limited to the beneficiaries on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bridges Community Ventures Limited (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 02 nov 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 19 oct 2007
    Entregado el 30 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew Hinton
    Transacciones
    • 30 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 oct 2007
    Entregado el 30 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Andrew Peter Hinton 2001 Accumulation and Maintenance Settlement
    Transacciones
    • 30 oct 2007Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 oct 2007
    Entregado el 30 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ian Bryan
    Transacciones
    • 30 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 oct 2007
    Entregado el 30 oct 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nicholas Wyatt
    Transacciones
    • 30 oct 2007Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 19 oct 2007
    Entregado el 30 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Martin Gibson
    Transacciones
    • 30 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 05 jul 2007
    Entregado el 11 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jul 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 05 jul 2007
    Entregado el 10 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jul 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 15 oct 2004
    Entregado el 19 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0