DERBY HOUSE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDERBY HOUSE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04330122
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DERBY HOUSE LIMITED?

    • Venta al por menor por correo o por Internet (47910) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra DERBY HOUSE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DERBY HOUSE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DERBY HOUSE GROUP LIMITED23 abr 200223 abr 2002
    BROOMCO (2734) LIMITED28 nov 200128 nov 2001

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DERBY HOUSE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para DERBY HOUSE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DERBY HOUSE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 28 nov 2014

    16 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 28 may 2014

    15 páginas2.24B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    8 páginas2.16B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    12 páginas1.4

    Domicilio social registrado cambiado de Derby House Ltd Mossy Lea Road Wrightington Wigan Lancashire WN6 9RE England el 16 dic 2013

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cancelación total de la carga 1

    3 páginasMR04

    Resumen de ingresos y gastos del supervisor del acuerdo voluntario hasta 25 ene 2013

    13 páginas1.3

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital01 feb 2013

    Estado de capital el 01 feb 2013

    • Capital: GBP 11,000,002
    SH01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 ene 2012

    22 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 ago 2012 au 31 ene 2012

    1 páginasAA01

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 ago 2011

    22 páginasAA

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 mar 2012Second filing AP01 for Martin Turley.

    second-filing-of-form-with-form-type

    5 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 mar 2012Second filing AP01 for Christopher Storr.

    second-filing-of-form-with-form-type

    6 páginasRP04
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 mar 2012Second filing AP01 for Mark Reeves

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    8 páginas1.1

    Nombramiento de Mr Christopher James Storr como director el 23 dic 2011

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 mar 2012A second filed AP01 was registered on 29/03/2012

    Nombramiento de Mr Martin Turley como director

    2 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 mar 2012A second filed AP01 was registered on 29/03/2012

    Nombramiento de Mr Martin Turley como director el 23 dic 2011

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mark Reeves como director el 23 dic 2011

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 mar 2012A second filed AP01 was registered on 29/03/2012

    Domicilio social registrado cambiado de Units 1-2 Holland Business Park Spa Lane Lathom Ormskirk Lancashire L40 6LN el 12 ene 2012

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 28 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Exercice comptable précédent prolongé du 28 feb 2011 au 31 ago 2011

    1 páginasAA01

    ¿Quiénes son los directivos de DERBY HOUSE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    STORR, Christopher
    Hollington
    DE6 3GB Ashbourne
    The Grange
    Derbyshire
    United Kingdom
    Secretario
    Hollington
    DE6 3GB Ashbourne
    The Grange
    Derbyshire
    United Kingdom
    149617140001
    CAYZER, Nigel Kenneth, Mr.
    Thriepley House
    Lundie
    DD2 5PA Dundee
    Director
    Thriepley House
    Lundie
    DD2 5PA Dundee
    United KingdomBritish16957900001
    REEVES, Mark Mark
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Buckinghamshire
    Director
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Buckinghamshire
    EnglandBritish165892400001
    STORR, Christopher James
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Buckinghamshire
    Director
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish114849640001
    TURLEY, Martin
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Buckinghamshire
    Director
    Station Road
    SL7 1NS Marlow
    81
    Buckinghamshire
    EnglandBritish165892460001
    ALEXANDER, Morag
    78 Nolt Loan Road
    DD11 2AB Arbroath
    Angus
    Secretario
    78 Nolt Loan Road
    DD11 2AB Arbroath
    Angus
    British81204310001
    AUKETT, Bryan Courtney
    22 Newlands Road
    Rottingdean
    BN2 7GD Brighton
    East Sussex
    Secretario
    22 Newlands Road
    Rottingdean
    BN2 7GD Brighton
    East Sussex
    British74358150001
    BUTLER, Peter Mark
    50 Manor Road
    Bramhall
    SK7 3LY Stockport
    Cheshire
    Secretario
    50 Manor Road
    Bramhall
    SK7 3LY Stockport
    Cheshire
    British67767420005
    TILLING, Christopher John
    1b Clifford Street
    Whitecross
    HR4 0HG Hereford
    Herefordshire
    Secretario
    1b Clifford Street
    Whitecross
    HR4 0HG Hereford
    Herefordshire
    British108665080001
    TOUGH, David
    48 Moyness Park Drive
    PH10 6LX Blairgowrie
    Perthshire
    Secretario
    48 Moyness Park Drive
    PH10 6LX Blairgowrie
    Perthshire
    British380610001
    TOUGH, David
    48 Moyness Park Drive
    PH10 6LX Blairgowrie
    Perthshire
    Secretario
    48 Moyness Park Drive
    PH10 6LX Blairgowrie
    Perthshire
    British380610001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    AUKETT, Bryan Courtney
    22 Newlands Road
    Rottingdean
    BN2 7GD Brighton
    East Sussex
    Director
    22 Newlands Road
    Rottingdean
    BN2 7GD Brighton
    East Sussex
    EnglandBritish74358150001
    BARTON, Andrew Firebrace
    Brackmont Farmhouse
    Balmullo
    KY16 0BJ St Andrews
    Fife
    Director
    Brackmont Farmhouse
    Balmullo
    KY16 0BJ St Andrews
    Fife
    British81204240002
    BRADFIELD, David Warren
    Ridgeway
    Hampton Bishop
    HR1 4JU Hereford
    Herefordshire
    Director
    Ridgeway
    Hampton Bishop
    HR1 4JU Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish66000710002
    BURROWS, Paula Dianne
    Little Perrugge
    Pudding Street
    HR2 0DN Rowlestone
    Herefordshire
    Director
    Little Perrugge
    Pudding Street
    HR2 0DN Rowlestone
    Herefordshire
    British84405880001
    BUTLER, Peter Mark
    50 Manor Road
    Bramhall
    SK7 3LY Stockport
    Cheshire
    Director
    50 Manor Road
    Bramhall
    SK7 3LY Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish67767420005
    DICKSON, John Paul
    Derby House
    Newburgh
    WN8 7NF Parbold
    Lancashire
    Director
    Derby House
    Newburgh
    WN8 7NF Parbold
    Lancashire
    British82705150001
    FINNIGAN, Norman
    19 Stonegate
    BD16 4SA Bingley
    West Yorkshire
    Director
    19 Stonegate
    BD16 4SA Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish29425700001
    GATEHOUSE, Ashley
    2 Furbers Barn Cottages
    Dorchester Road, Stratton
    DT2 9RU Dorchester
    Dorset
    Director
    2 Furbers Barn Cottages
    Dorchester Road, Stratton
    DT2 9RU Dorchester
    Dorset
    British109943830001
    GREALEY, Martyn
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    Director
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    United KingdomBritish125401590001
    OMALLEY, Michael Dara
    8a Hoscote Park
    West Kirby
    CH48 0QW Wirral
    Director
    8a Hoscote Park
    West Kirby
    CH48 0QW Wirral
    British100793510002
    SIMPSON, Michael
    9 Carnoustie Drive
    MK40 4FE Great Denham
    Bedfordshire
    Director
    9 Carnoustie Drive
    MK40 4FE Great Denham
    Bedfordshire
    United KingdomBritish101016020001
    TILLING, Christopher John
    1b Clifford Street
    Whitecross
    HR4 0HG Hereford
    Herefordshire
    Director
    1b Clifford Street
    Whitecross
    HR4 0HG Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish108665080001
    WOOLF, John Nicholas
    Wyngates
    Portsmouth Road
    KT10 9JA Esher
    Surrey
    Director
    Wyngates
    Portsmouth Road
    KT10 9JA Esher
    Surrey
    EnglandBritish94825590001
    WRIGHT, John Robertson
    Ednam Mains House
    Ednam
    TD5 7QL Kelso
    Director
    Ednam Mains House
    Ednam
    TD5 7QL Kelso
    United KingdomBritish118658470001
    YATES, John-Paul
    Holden Road
    WN7 2HG Leigh
    308
    Lancashire
    Director
    Holden Road
    WN7 2HG Leigh
    308
    Lancashire
    EnglandBritish139074540001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    ¿Tiene DERBY HOUSE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 dic 2004
    Entregado el 16 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cayzer Continuation Pcc Limited
    Transacciones
    • 16 dic 2004Registro de un cargo (395)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creado el 17 abr 2002
    Entregado el 23 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ago 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene DERBY HOUSE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    26 ene 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    23 dic 2013Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon James Bonney
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Buckinghamshire
    Profesional
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Buckinghamshire
    2
    FechaTipo
    29 nov 2013Inicio de la administración
    28 nov 2014Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon James Bonney
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Profesional
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Christopher Newell
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks
    Profesional
    81 Station Road
    SL7 1NS Marlow
    Bucks

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0